Actos BORME de Villanueva Cosolar Sl
17 de Junio de 2019Ceses/Dimisiones. Representan: VALENCIA MU脩OZ PABLO. Revocaciones. Apo.Sol.: OLAGUIBEL AMICH I脩IGO;VALENCIAMU脩OZ PABLO;PEREZ MARCOS OSCAR;ASUERO RESUSTA VICENTE;GIMENEZ SORIANO PABLO;PAREJO DEL RIO DANIEL.Nombramientos. Representan: GARCIA MASCU脩AN MIGUEL ANGEL. Apo.Sol.: FERNANDEZ FERNANDEZ JUANMANUEL;GONZALEZ HERNANDEZ GERSON JOSE. Cambio de domicilio social. C/ PRINCIPE DE VERGARA 108 (MADRID).Datos registrales. T 34339 , F 59, S 8, H M 617761, I/A 5 (10.06.19).
27 de Junio de 2016Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 5.562.625,00 Euros. Resultante Suscrito: 3.000,00 Euros. Datos registrales. T 34339 , F58, S 8, H M 617761, I/A 4 (17.06.16).
17 de Marzo de 2016Nombramientos. Apo.Sol.: OLAGUIBEL AMICH I脩IGO;VALENCIA MU脩OZ PABLO;PEREZ MARCOS OSCAR;ASUERO RESUSTAVICENTE;GIMENEZ SORIANO PABLO;PAREJO DEL RIO DANIEL. Datos registrales. T 34339 , F 55, S 8, H M 617761, I/A 3 (9.03.16).
12 de Febrero de 2016Cambio de domicilio social. C/ JENNER 3 4 (MADRID). Datos registrales. T 34339 , F 55, S 8, H M 617761, I/A 2 ( 5.02.16).
15 de Enero de 2016Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: VELA ENERGY HOLDINGS SL. Ceses/Dimisiones. Presidente:MARQUES PEDRALVA DELGADO ALDA MARIA. Con.Delegado: MARQUES PEDRALVA DELGADO ALDA MARIA. Consejero:MARQUES PEDRALVA DELGADO ALDA MARIA;SANTOS PINTOR FRANCISCO ARTUR;MARQUES DOMINGOS ANA LOURDES.
22 de Mayo de 2013Ceses/Dimisiones. Consejero: GOMES BAPTISTA JOSE LUIS. Nombramientos. Consejero: MARQUES DOMINGOS ANALOURDES. Datos registrales. T 2264 , F 209, S 8, H CO 31757, I/A 4 (15.05.13).
01 de Junio de 2012Ceses/Dimisiones. Consejero: DIAS CAETANO PAULO ALEXANDRE. Nombramientos. Consejero: GOMES BAPTISTA JOSELUIS. Datos registrales. T 2264 , F 209, S 8, H CO 31757, I/A 3 (24.05.12).
15 de Febrero de 2012Cambio de domicilio social. CTRA A-424 Km 30,3 - FINCA GUSANITOS, POLIGONO 68, (VILLANUEVA DE CORDOBA). Datosregistrales. T 2264 , F 209, S 8, H CO 31757, I/A 2 ( 6.02.12).