Actos BORME de Vinicola De Castilla Sociedad Anonima
17 de Agosto de 2023Nombramientos. Apo.Sol.: BELLIDO SERRANO SONIA. Datos registrales. T 714 , F 220, S 8, H CR 2667, I/A 38 ( 9.08.23).
06 de Junio de 2023Revocaciones. Apoderado: SOTO GALAN ALVARO. Datos registrales. T 667 , F 168, S 8, H CR 2667, I/A 37 (30.05.23).
28 de Marzo de 2023Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 227.182,57 Euros. Resultante Suscrito: 1.395.550,10 Euros. Datos registrales. T 667 , F168, S 8, H CR 2667, I/A 36 (15.03.23).
23 de Enero de 2023Cambio de domicilio social. POLIG INDUSTRIAL, S/N - CALLE UNION EUROPEA -PARCE (MANZANARES). Datos registrales. T667 , F 168, S 8, H CR 2667, I/A 35 (16.01.23).
08 de Junio de 2021Ceses/Dimisiones. Consejero: MONSALVE MU脩OZ ALFONSO. Datos registrales. T 667 , F 167, S 8, H CR 2667, I/A 34 ( 1.06.21).
25 de Mayo de 2021Nombramientos. Apoderado: BELLIDO SERRANO SONIA. Datos registrales. T 667 , F 166, S 8, H CR 2667, I/A 33 (18.05.21).
11 de Noviembre de 2020Revocaciones. Apo.Sol.: CAMACHO MAESO ANTONIO JESUS. Datos registrales. T 667 , F 166, S 8, H CR 2667, I/A 32 (3.11.20).
05 de Mayo de 2020Nombramientos. Consejero: BELLIDO SERRANO SONIA;LAVI脩A RICHI EDUARDO;MONSALVE MU脩OZ ALFONSO. Datosregistrales. T 667 , F 166, S 8, H CR 2667, I/A 31 ( 1.04.20).
25 de Febrero de 2020Nombramientos. Apoderado: BELLIDO SERRANO SONIA. Datos registrales. T 667 , F 166, S 8, H CR 2667, I/A 30 (17.02.20).
05 de Noviembre de 2019Cambio de domicilio social. POLIG INDUSTRIAL S/N CALLE I, -PARCELA 5 (MANZANARES). Datos registrales. T 484 , F 224, S8, H CR 2667, I/A 29 (24.10.19).
20 de Agosto de 2019Reelecciones. Consejero: BELLIDO QUINTIAN FELIX;BELLIDO QUINTIAN ALBERTO;BELLIDO CUELLAR DAVID;GRANADOSPATON PEDRO. Cons.Del.Sol: BELLIDO QUINTIAN FELIX. Presidente: BELLIDO QUINTIAN FELIX. Secretario: BELLIDO QUINTIANALBERTO. Datos registrales. T 484 , F 224, S 8, H CR 2667, I/A 28 ( 5.08.19).
19 de Marzo de 2019Ceses/Dimisiones. Consejero: GARCIA LOPEZ LUIS. Modificaciones estatutarias. Modificados los art铆culos 25潞 y 28 de losestatutos sociales. Datos registrales. T 484 , F 224, S 8, H CR 2667, I/A 27 ( 8.03.19).
28 de Enero de 2019Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 0,01 Euros. Resultante Suscrito: 1.803.036,30 Euros. Datos registrales. T 484 , F 223, S8, H CR 2667, I/A 25 (17.01.19).
Nombramientos. Secretario: BELLIDO QUINTIAN ALBERTO. Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 180.303,63 Euros.Resultante Suscrito: 1.622.732,67 Euros. Modificaciones estatutarias. MODIFICADO el ARTICULO 31 de los ESTATUTOSreferente a la retribuci贸n del 贸rgano de Administraci贸n. . Datos registrales. T 484 , F 224, S 8, H CR 2667, I/A 26 (17.01.19).
28 de Noviembre de 2018Nombramientos. Apoderado: BELLIDO QUINTIAN ALBERTO. Datos registrales. T 484 , F 222, S 8, H CR 2667, I/A 24 (15.11.18).
02 de Noviembre de 2018Nombramientos. Apo.Sol.: CAMACHO MAESO ANTONIO JESUS;GONZALEZ-CALERO MASCARAQUE MARIAENCARNACION;NAVARRO MARTIN MANUEL. Datos registrales. T 484 , F 222, S 8, H CR 2667, I/A 22 (22.10.18).
Revocaciones. Apo.Man.Soli: GONZALEZ-CALERO MASCARAQUE ENCARNACION;NAVARRO MARTIN MANUEL. Apoderado:CAMACHO MAESO ANTONIO JESUS. Datos registrales. T 484 , F 222, S 8, H CR 2667, I/A 23 (22.10.18).
11 de Septiembre de 2018Ceses/Dimisiones. Consejero: MONSALVE MU脩OZ ALFONSO. Secretario: MONSALVE MU脩OZ ALFONSO. Cons.Del.Sol:MONSALVE MU脩OZ ALFONSO. Revocaciones. Apoderado: MONSALVE MU脩OZ ALFONSO. Datos registrales. T 484 , F 222, S8, H CR 2667, I/A 21 ( 7.08.18).
17 de Abril de 2017Nombramientos. Consejero: BELLIDO CUELLAR DAVID. Datos registrales. T 484 , F 221, S 8, H CR 2667, I/A 20 ( 5.04.17).
01 de Diciembre de 2016Revocaciones. Apo.Manc.: MERAS RIVAS JULIO;ALVAREZ PUEYO GERARDO. Apo.Man.Soli: ALVAREZ PUEYOGERARDO;GONZALEZ-CALERO MASCARAQUE MARIA ENCARNACION. Datos registrales. T 484 , F 221, S 8, H CR 2667, I/A 18(16.11.16).
Nombramientos. Apoderado: CAMACHO MAESO ANTONIO JESUS. Datos registrales. T 484 , F 221, S 8, H CR 2667, I/A 19(16.11.16).
15 de Febrero de 2016Ceses/Dimisiones. Consejero: BELLIDO QUINTIAN MIGUEL. Datos registrales. T 484 , F 221, S 8, H CR 2667, I/A 17 (15.01.16).
18 de Junio de 2015Reelecciones. Consejero: BELLIDO QUINTIAN FELIX;BELLIDO QUINTIAN ALBERTO;MONSALVE MU脩OZ ALFONSO;BELLIDOQUINTIAN MIGUEL;GARCIA LOPEZ LUIS;GRANADOS PATON PEDRO. Presidente: BELLIDO QUINTIAN FELIX. Secretario:MONSALVE MU脩OZ ALFONSO. Cons.Del.Sol: MONSALVE MU脩OZ ALFONSO;BELLIDO QUINTIAN FELIX. Datos registrales. T484 , F 220, S 8, H CR 2667, I/A 16 ( 8.06.15).
18 de Marzo de 2015Nombramientos. Apo.Man.Soli: GONZALEZ-CALERO MASCARAQUE ENCARNACION;NAVARRO MARTIN MANUEL. Datosregistrales. T 484 , F 220, S 8, H CR 2667, I/A 15 ( 5.03.15).
14 de Junio de 2010Reelecciones. Consejero: BELLIDO QUINTIAN FELIX;BELLIDO QUINTIAN ALBERTO;MONSALVE MU脩OZ ALFONSO;BELLIDOQUINTIAN MIGUEL;GARCIA LOPEZ LUIS;GRANADOS PATON PEDRO. Presidente: BELLIDO QUINTIAN FELIX. Con.Delegado:BELLIDO QUINTIAN FELIX. Secretario: MONSALVE MU脩OZ ALFONSO. Cons.Del.Sol: MONSALVE MU脩OZ ALFONSO. Datosregistrales. T 484 , F 220, S 8, H CR 2667, I/A 14 ( 2.06.10).
19 de Octubre de 2009Nombramientos. Apo.Man.Soli: GONZALEZ-CALERO MASCARAQUE MARIA ENCARNACION;NAVARRO MARTIN MANUEL.Datos registrales. T 86 , F 68, S 8, H CR 2667, I/A 13 (15.09.09).