Actos BORME de Viso Farmaceutica Sl
08 de Septiembre de 2022Revocaciones. Apo.Manc.: GARCIA PEREZ ROSA ANA. Datos registrales. T 33533 , F 201, S 8, H M 603598, I/A 17 ( 1.09.22).
Nombramientos. Apo.Manc.: TARCIZO DE FARIA ROBSON. Datos registrales. T 33533 , F 201, S 8, H M 603598, I/A 18 (1.09.22).
Nombramientos. Apo.Manc.: MU脩OZ DOMINGUEZ MARGARITA. Datos registrales. T 33533 , F 201, S 8, H M 603598, I/A 19 (1.09.22).
29 de Diciembre de 2021Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: BOURNE OLIVER HENRY;GUPTA ACHIN. Nombramientos. Adm. Unico: BOURNE OLIVERHENRY. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Administradores solidarios a Administrador 煤nico. Datosregistrales. T 33533 , F 201, S 8, H M 603598, I/A 16 (22.12.21).
30 de Septiembre de 2021Nombramientos. Auditor: ALESCO PARTNERS SLP. Datos registrales. T 33533 , F 201, S 8, H M 603598, I/A 15 (23.09.21).
26 de Marzo de 2019Nombramientos. Apo.Manc.: GARCIA PEREZ ROSA ANA. Datos registrales. T 33533 , F 200, S 8, H M 603598, I/A 14 (19.03.19).
19 de Noviembre de 2018Nombramientos. Apoderado: LOPEZ SANCHEZ JOSE RAMON. Datos registrales. T 33533 , F 200, S 8, H M 603598, I/A 13(12.11.18).
14 de Noviembre de 2018Revocaciones. Apoderado: MU脩OZ CORDERO MARIA DEL MAR. Apo.Manc.: MU脩OZ CORDERO MARIA DEL MAR. Apo.Sol.:MU脩OZ CORDERO MARIA DEL MAR. Datos registrales. T 33533 , F 200, S 8, H M 603598, I/A 12 ( 6.11.18).
02 de Noviembre de 2018Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: BOURNE OLIVER HENRY. Nombramientos. Adm. Solid.: BOURNE OLIVER HENRY;GUPTAACHIN. Modificaciones estatutarias. Refundici贸n de los estatutos sociales.. Otros conceptos: Cambio del Organo deAdministraci贸n: Administrador 煤nico a Administradores solidarios. Cambio de domicilio social. C/ RETAMA 7 7 (MADRID). Datosregistrales. T 33533 , F 7, S 8, H M 603598, I/A 11 (25.10.18).
31 de Octubre de 2017Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: ATTEWELL CARL STEPHEN;BOURNE OLIVER HENRY. Nombramientos. Adm. Unico: BOURNEOLIVER HENRY. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Administradores solidarios a Administrador 煤nico. Datosregistrales. T 33533 , F 7, S 8, H M 603598, I/A 10 (24.10.17).
17 de Marzo de 2017Nombramientos. Apo.Sol.: LOPEZ SANCHEZ JOSE RAMON;MU脩OZ CORDERO MARIA DEL MAR. Datos registrales. T 33533 , F6, S 8, H M 603598, I/A 9 (10.03.17).
30 de Diciembre de 2016Nombramientos. Apo.Man.Soli: LOPEZ SANCHEZ JOSE RAMON. Apo.Manc.: BOURNE OLIVER HENRY;ATTEWELL CARLSTEPHEN. Datos registrales. T 33533 , F 5, S 8, H M 603598, I/A 6 (21.12.16).
Nombramientos. Apo.Manc.: MU脩OZ CORDERO MARIA DEL MAR. Datos registrales. T 33533 , F 6, S 8, H M 603598, I/A 7(21.12.16).
Revocaciones. Apoderado: MU脩OZ CORDERO MARIA DEL MAR. Apo.Man.Soli: LOPEZ SANCHEZ JOSE RAMON. Datosregistrales. T 33533 , F 6, S 8, H M 603598, I/A 8 (21.12.16).
04 de Octubre de 2016Nombramientos. Apo.Man.Soli: LOPEZ SANCHEZ JOSE RAMON. Datos registrales. T 33533 , F 4, S 8, H M 603598, I/A 5(26.09.16).
05 de Mayo de 2016Nombramientos. Apoderado: MU脩OZ CORDERO MARIA DEL MAR. Datos registrales. T 33533 , F 3, S 8, H M 603598, I/A 4(27.04.16).
23 de Diciembre de 2015Nombramientos. Apoderado: MU脩OZ CORDERO MARIA DEL MAR;PAL NABIN CHANDRA;TYLER MICHELLE JACQUELINE.Datos registrales. T 33533 , F 3, S 8, H M 603598, I/A 3 (16.12.15).
21 de Septiembre de 2015Nombramientos. Apoderado: PAL NABIN CHANDRA;TYLER MICHELLE JACQUELINE. Datos registrales. T 33533 , F 3, S 8, H M603598, I/A 2 (14.09.15).
09 de Junio de 2015Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 28.04.15. Objeto social: LA PRODUCCION ELABORACION COMERCIALIZACIONEXPORTACION E IMPORTACION Y REPRESENTACION DE PRODUCTOS QUIMICOS, ANTIBIOTICOS SUSTANCIAS OPREPARADOS MEDICAMENTOSOS ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS GENERICASFORMULAS MAGISTRALES. PRODUCTOS SANITARIOS. ALIMENTOS INFANTILES. Domicilio: C/ RIVERA DEL LOIRA 46 -CAMPO DE LAS NACIONES (MADRID). Capital: 3.000,00 Euros. Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: GLENMARKHOLDING SA. Nombramientos. Adm. Solid.: ATTEWELL CARL STEPHEN;BOURNE OLIVER HENRY. Datos registrales. T 33533 ,F 1, S 8, H M 603598, I/A 1 (28.05.15).