Actos BORME de Vistra Administration Services Sl
20 de Julio de 2022Revocaciones. ADM.SOLIDAR.: REYES SOSA DANIELA SALIME;NUET BLANCH FRANCISCO JAVIER. APODERAD.SOL: MORELOPEZ MARIA VICTORIA. Nombramientos. ADM.CONJUNTO: STEVEN FRANK HENDRIK VAN TUIJL;MARK ROBERT WALLACEJONES. Datos registrales. T 41223 , F 151, S 8, H B 383170, I/A 14 (11.07.22).
Nombramientos. APOD.SOL/MAN: ORTEGA FRANCO BERTA CLARA;NUET BLANCH FRANCISCO JAVIER;BLASI CASADOMARCOS;SANCHEZ NIETO SOLEDAD. Datos registrales. T 41223 , F 152, S 8, H B 383170, I/A 15 (11.07.22).
29 de Enero de 2019Nombramientos. APODERAD.SOL: MORE LOPEZ MARIA VICTORIA. Datos registrales. T 41223 , F 151, S 8, H B 383170, I/A 13(21.01.19).
14 de Enero de 2019Modificaciones estatutarias. ARTICULO 17.- SISTEMA RETRIBUTIVO DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL. Datosregistrales. T 41223 , F 151, S 8, H B 383170, I/A 12 ( 4.01.19).
22 de Mayo de 2018Revocaciones. ADM.SOLIDAR.: OLIVER DE QUEROL MARIA VICTORIA. Datos registrales. T 41223 , F 151, S 8, H B 383170, I/A11 (15.05.18).
12 de Abril de 2018Nombramientos. ADM.SOLIDAR.: NUET BLANCH FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 41223 , F 150, S 8, H B 383170, I/A10 ( 4.04.18).
15 de Diciembre de 2017Revocaciones. ADM.SOLIDAR.: GARCIA COLLADO OSCAR. Datos registrales. T 41223 , F 150, S 8, H B 383170, I/A 9 ( 1.12.17).
13 de Abril de 2016Revocaciones. ADM.SOLIDAR.: REVIRIEGO COLL JOSE LUIS. Datos registrales. T 41223 , F 150, S 8, H B 383170, I/A 8 (6.04.16).
31 de Agosto de 2015Revocaciones. ADM.SOLIDAR.: AGUILAR GONZALEZ MANUEL. Datos registrales. T 41223 , F 150, S 8, H B 383170, I/A 7(24.08.15).
20 de Marzo de 2015Revocaciones. ADM.SOLIDAR.: MARTIN ANFRUNS ALFRED;LOPEZ GINES ALBERTO. Datos registrales. T 41223 , F 150, S 8,H B 383170, I/A 6 (11.03.15).
04 de Junio de 2014Nombramientos. ADM.SOLIDAR.: REYES SOSA DANIELA SALIME. Modificaciones estatutarias. ART.13: ESTRUCTURA DELORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL. Datos registrales. T 41223 , F 149, S 8, H B 383170, I/A 5 (27.05.14).