Actos BORME de Vitakraft Spain Sl
28 de Diciembre de 2022Reelecciones. Auditor: CROWE SERVICIOS DE AUDITORIA SLP. Datos registrales. T 35261 , F 140, S 8, H M 245395, I/A 31(20.12.22).
14 de Marzo de 2022Nombramientos. Apo.Sol.: GIENAU GUDRUN. Datos registrales. T 35261 , F 140, S 8, H M 245395, I/A 30 ( 7.03.22).
27 de Febrero de 2020Cambio de domicilio social. C/ PLAYA DE LAS AMERICAS 2 - OFICINA 2.2 (ROZAS DE MADRID (LAS)). Datos registrales. T35261 , F 139, S 8, H M 245395, I/A 29 (20.02.20).
15 de Enero de 2020Reelecciones. Auditor: CROWE SERVICIOS DE AUDITORIA SLP. Datos registrales. T 35261 , F 139, S 8, H M 245395, I/A 28 (8.01.20).
29 de Enero de 2018Revocaciones. Apo.Manc.: GIENAU GUDRUN;ALONSO PEREZ JUAN CARLOS. Apo.Sol.: GIENAU GUDRUN;ALONSO PEREZJUAN CARLOS. Nombramientos. Apo.Sol.: GIENAU GUDRUN. Datos registrales. T 35261 , F 138, S 8, H M 245395, I/A 27(18.01.18).
28 de Marzo de 2017Nombramientos. Apo.Manc.: GIENAU GUDRUN;ALONSO PEREZ JUAN CARLOS. Datos registrales. T 14772 , F 120, S 8, H M245395, I/A 24 (16.03.17).
Nombramientos. Apo.Sol.: GIENAU GUDRUN. Datos registrales. T 35261 , F 136, S 8, H M 245395, I/A 25 (16.03.17).
Nombramientos. Apo.Sol.: ALONSO PEREZ JUAN CARLOS. Datos registrales. T 35261 , F 136, S 8, H M 245395, I/A 26(16.03.17).
10 de Febrero de 2017Revocaciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Nombramientos. Auditor: HORWATH AUDITORES ESPAÑA SOCIEDADLIMITADA PROFESI. Datos registrales. T 14772 , F 120, S 8, H M 245395, I/A 23 ( 1.02.17).
06 de Febrero de 2017Revocaciones. Apoderado: ALONSO PEREZ JUAN CARLOS;GIENAU GUDRUN;ALONSO PEREZ JUAN CARLOS;GIENAUGUDRUN;ALONSO PEREZ JUAN CARLOS. Datos registrales. T 14772 , F 120, S 8, H M 245395, I/A 22 (30.01.17).
23 de Mayo de 2016Nombramientos. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 14772 , F 119, S 8, H M 245395, I/A 21 (12.05.16).
05 de Abril de 2016Nombramientos. Apoderado: GIENAU GUDRUN;ALONSO PEREZ JUAN CARLOS. Datos registrales. T 14772 , F 118, S 8, H M245395, I/A 20 (23.03.16).
05 de Febrero de 2016Ceses/Dimisiones. VsecrNoConsj: CRUZ DE AGUIAR RAFAEL. Revocaciones. Apoderado: CRUZ DE AGUIAR RAFAEL;CRUZDE AGUIAR RAFAEL;CRUZ DE AGUIAR RAFAEL. Datos registrales. T 14772 , F 118, S 8, H M 245395, I/A 19 (28.01.16).
25 de Enero de 2016Nombramientos. Apoderado: GIENAU GUDRUN;ALONSO PEREZ JUAN CARLOS. Datos registrales. T 14772 , F 117, S 8, H M245395, I/A 18 (14.01.16).
19 de Febrero de 2015Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 14772 , F 117, S 8, H M 245395, I/A 17 (12.02.15).
18 de Septiembre de 2014Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 14772 , F 117, S 8, H M 245395, I/A 16 ( 5.09.14).
08 de Septiembre de 2014Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 14772 , F 116, S 8, H M 245395, I/A 15 ( 1.09.14).
03 de Abril de 2014Ceses/Dimisiones. Consejero: WUHRMANN HEIKO. Secretario: WUHRMANN HEIKO. Nombramientos. Consejero: GIENAUGUDRUN. Secretario: GIENAU GUDRUN. Datos registrales. T 14772 , F 116, S 8, H M 245395, I/A 14 (26.03.14).
21 de Mayo de 2013Ceses/Dimisiones. VsecrNoConsj: MUÑOZ ZAPATERO FRANCISCO JAVIER. Nombramientos. VsecrNoConsj: CRUZ DEAGUIAR RAFAEL. Datos registrales. T 14772 , F 116, S 8, H M 245395, I/A 13 (10.05.13).
01 de Febrero de 2011Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 14772 , F 115, S 8, H M 245395, I/A 12 (20.01.11).
17 de Enero de 2011Otros conceptos: MODIFICACION DE LOS PODERES OTORGADOS A FAVOR DE DON RAFAELCRUZ AGUILAR, OBJETO DELA INSCRIPCION 3& DE LA HOJA REGISTRAL. Datos registrales. T 14772 , F 115, S 8, H M 245395, I/A 11 ( 4.01.11).
19 de Mayo de 2010Ceses/Dimisiones. Secretario: LEHRE CRISTIAN. Cons.Del.Sol: LEHRE CRISTIAN. Consejero: LEHRE CRISTIAN. Presidente:HANSLI PETER. Consejero: HANSLI PETER. Nombramientos. Consejero: STRELOW DIRK;GARDEWIN HEINZ JOHANNES.Presidente: STRELOW DIRK. Secretario: WUHRMANN HEIKO. Datos registrales. T 14772 , F 115, S 8, H M 245395, I/A 10 (7.05.10).