Buscador CIF Logo

Actos BORME Vitro Automotriz Ue Sl

¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Vitro Automotriz Ue Sl

Actos BORME Vitro Automotriz Ue Sl - B01889492

Tenemos registrados 13 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Vitro Automotriz Ue Sl con CIF B01889492

🔙 Perfil de Vitro Automotriz Ue Sl
🛒 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Vitro Automotriz Ue Sl

30 de Octubre de 2023
Otros conceptos: Por adquisición de la nacionalidad española, se cambia el número de NIE X-5628166C, asignado al Consejero-Presidente Don Adrian Guadalupe Sada Cueva, por el DNI número 55452591-M.- Datos registrales. T 43723 , F 41, S 8, H M726364, I/A 12 (23.10.23).

27 de Abril de 2023
Revocaciones. Apoderado: ARECHAVALETA SANTOS JAVIER. Nombramientos. Apo.Man.Soli: DEL VALLE CABELLO CLAUDIOLUIS;COLOME CARRASCO RAFAEL;ARECHAVALETA SANTOS JAVIER Datos registrales. T 43723 , F 40, S 8, H M 726364, I/A 11(20.04.23).

13 de Octubre de 2022
Fe de erratas: Se publicó por error en la inscripción 1ª el nombramiento del socio único VITRO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITALVARIABLE siendo lo correcto VITRO, SOCIEDAD ANONIMA BURSATIL DE CAPITAL VARIABLE. Datos registrales. T 40949 , F 30,S 8, H M 726364, I/A 1 (25.09.20).

04 de Julio de 2022
Nombramientos. Aud.C.Con.: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 40949 , F 39, S 8, H M 726364, I/A 10 (27.06.22).

22 de Diciembre de 2021
Nombramientos. Apoderado: MENDEZ DIAZ HERMINIO. Datos registrales. T 40949 , F 38, S 8, H M 726364, I/A 8 (15.12.21).

Ceses/Dimisiones. Consejero: SADA GONZALEZ ADRIAN GUADALUPE. Presidente: SADA GONZALEZ ADRIAN GUADALUPE.Nombramientos. Consejero: SADA CUEVA ADRIAN GUADALUPE. Presidente: SADA CUEVA ADRIAN GUADALUPE. Datosregistrales. T 40949 , F 39, S 8, H M 726364, I/A 9 (15.12.21).

21 de Octubre de 2021
Nombramientos. Apo.Sol.: MENDEZ DIAZ HERMINIO. Datos registrales. T 40949 , F 37, S 8, H M 726364, I/A 7 (14.10.21).

19 de Enero de 2021
Nombramientos. Apo.Sol.: DEL VALLE CABELLO CLAUDIO LUIS;FLORES DELSOL RICARDO;RODELA LUNA JORGEALBERTO;ARECHAVALETA SANTOS JAVIER;MORALES GONZALEZ MAURICIO ALEJANDRO. Apo.Manc.: DEL VALLE CABELLOCLAUDIO LUIS;FLORES DELSOL RICARDO;RODELA LUNA JORGE ALBERTO;ARECHAVALETA SANTOS JAVIER. Datosregistrales. T 40949 , F 37, S 8, H M 726364, I/A 6 (12.01.21).

15 de Enero de 2021
Nombramientos. Apoderado: DEL VALLE CABELLO CLAUDIO LUIS;CONTRERAS VILLAFRANCA RAUL ARMANDO;FLORESDELSOL RICARDO;RODRIGUEZ GUZMAN NORMA PATRICIA;RODELA LUNA JORGE ALBERTO. Datos registrales. T 40949 , F36, S 8, H M 726364, I/A 5 ( 8.01.21).

14 de Diciembre de 2020
Nombramientos. Apo.Sol.: GARCIA LOPEZ LUIS MANUEL;ANTUÑA PELEGRI ANA;ESPINOLA TELLO SHANON;ESPINOLATELLO SHANON. Datos registrales. T 40949 , F 33, S 8, H M 726364, I/A 4 ( 3.12.20).

02 de Octubre de 2020
Constitución. Comienzo de operaciones: 2.09.20. Objeto social: El objeto social de la Sociedad es la tenencia de acciones y

Nombramientos. SecreNoConsj: GARCIA LOPEZ LUIS MANUEL. Presidente: SADA GONZALEZ ADRIAN GUADALUPE. Datosregistrales. T 40949 , F 31, S 8, H M 726364, I/A 2 (25.09.20).

Nombramientos. Apoderado: ARECHAVALETA SANTOS JAVIER. Datos registrales. T 40949 , F 31, S 8, H M 726364, I/A 3(25.09.20).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información