Actos BORME de Vitrogar Sa
05 de Diciembre de 2014Disoluci贸n. Fusion. Extinci贸n. Datos registrales. T 3314 , F 220, S 8, H Z 1465, I/A 46 C (28.11.14).
17 de Noviembre de 2014Otros conceptos: CERRADA LA HOJA, por plazo provisional de 6 meses, conforme al art铆culo 231 del Reglamento del RegistroMercantil. Datos registrales. T 3314 , F 220, S 8, H Z 1465, I/A 46 F ( 6.11.14).
23 de Octubre de 2013Revocaciones. Auditor: ENRIQUE CAMPOS & CIA CENSORES JURADOS DE CUENTAS A. Nombramientos. Auditor:PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 3314 , F 220, S 8, H Z 1465, I/A 46(15.10.13).
17 de Mayo de 2013Revocaciones. Apoderado: DIAZ GUIJARRO ALBERTO. Apo.Sol.: DIAZ GUIJARRO ALBERTO. Datos registrales. T 3314 , F 219,S 8, H Z 1465, I/A 44 ( 8.05.13).
Ceses/Dimisiones. Consejero: BORQUE CESPEDES RAFAEL. Con.Delegado: BORQUE CESPEDES RAFAEL. Consejero: GRAFKLAUS. Presidente: GRAF KLAUS. Con.Delegado: GRAF KLAUS. Consejero: RECIO FERNANDEZ DIEGO. Nombramientos.Consejero: BALDASANO SUPERVIELLE ARTURO. Presidente: BALDASANO SUPERVIELLE ARTURO. Consejero: BECHMARTIN;BORQUE CESPEDES RAFAEL. Cons.Del.Sol: BALDASANO SUPERVIELLE ARTURO;BORQUE CESPEDES RAFAEL.Datos registrales. T 3314 , F 219, S 8, H Z 1465, I/A 45 ( 8.05.13).
09 de Agosto de 2012Ceses/Dimisiones. Consejero: DIAZ GUIJARRO ALBERTO. Secretario: DIAZ GUIJARRO ALBERTO. Nombramientos. Consejero:RECIO FERNANDEZ DIEGO. SecreNoConsj: FERNANDEZ LOPEZ MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 3314 , F 219, S 8, H Z1465, I/A 43 (31.07.12).
12 de Junio de 2012Revocaciones. Apoderado: GARCIA ARIZA JESUS. Datos registrales. T 3314 , F 219, S 8, H Z 1465, I/A 42 (31.05.12).
17 de Octubre de 2011Nombramientos. Apoderado: GARCIA ARIZA JESUS. Datos registrales. T 3314 , F 219, S 8, H Z 1465, I/A 41 ( 4.10.11).
22 de Septiembre de 2011Reelecciones. Auditor: ENRIQUE CAMPOS & CIA CENSORES JURADOS DE CUENTAS A. Datos registrales. T 3314 , F 219, S 8,H Z 1465, I/A 40 (12.09.11).
29 de Noviembre de 2010Ceses/Dimisiones. Consejero: SANZ ARRANZ MIGUEL ANGEL. Nombramientos. Consejero: BORQUE CESPEDES RAFAEL.Con.Delegado: BORQUE CESPEDES RAFAEL. Reelecciones. Consejero: GRAF KLAUS. Presidente: GRAF KLAUS. Con.Delegado:GRAF KLAUS. Datos registrales. T 3314 , F 218, S 8, H Z 1465, I/A 39 (18.11.10).
12 de Junio de 2009Revocaciones. Apoderado: SANZ ARRANZ MIGUEL ANGEL;SANZ ARRANZ MIGUEL ANGEL. Nombramientos. Apo.Sol.: DIAZGUIJARRO ALBERTO;BALDASANO SUPERVIELLE ARTURO. Datos registrales. T 3314 , F 218, S 8, H Z 1465, I/A 38 ( 2.06.09).
29 de Mayo de 2009Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: TEKA INDUSTRIAL SA. Datos registrales. T 3314 , F 218, S 8, H Z 1465, I/A 37(20.05.09).
16 de Enero de 2009Nombramientos. Apo.Sol.: BORQUE CESPEDES RAFAEL. Datos registrales. T 3314 , F 218, S 8, H Z 1465, I/A 36 ( 5.01.09).
07 de Enero de 2009Reelecciones. Auditor: ENRIQUE CAMPOS & CIA CENSORES JURADOS DE CUENTAS A. Datos registrales. T 3314 , F 218, S 8,H Z 1465, I/A 35 (23.12.08).