Actos BORME de Viveme Real Estate Management Sociedad Limitada
18 de Septiembre de 2023Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 7.528,40 Euros. Resultante Suscrito: 378.085,40 Euros. Datos registrales. T 32766 , F 75,S 8, H M 589783, I/A 15 (11.09.23).
28 de Agosto de 2023Nombramientos. Auditor: AUDITRUST AUDITORES SLP. Datos registrales. T 32766 , F 74, S 8, H M 589783, I/A 14 (21.08.23).
12 de Abril de 2021Cambio de domicilio social. C/ SEGUNDO MATA 1 3陋 - OFICINA 11 (POZUELO DE ALARCON). Datos registrales. T 32766 , F74, S 8, H M 589783, I/A 12 ( 5.04.21).
03 de Febrero de 2021Nombramientos. Auditor: AUDITRUST AUDITORES SLP. Datos registrales. T 32766 , F 74, S 8, H M 589783, I/A 11 (27.01.21).
20 de Septiembre de 2018Modificaciones estatutarias. Modificaci贸n del art铆culo 16潞 de los estatutos sociales.. Datos registrales. T 32766 , F 73, S 8, H M589783, I/A 10 (12.09.18).
07 de Junio de 2018Cambio de domicilio social. C/ CERRO DE VALDECAHONDE 18 1潞 B (MADRID). Datos registrales. T 32766 , F 73, S 8, H M589783, I/A 9 (30.05.18).
22 de Febrero de 2018Ceses/Dimisiones. Consejero: AGREE REHABILITACION Y EFICIENCIA ENERGETICA SL;JUBARTA CONSULTORIA SL;CAMPODE LOZOYA SL. Presidente: AGREE REHABILITACION Y EFICIENCIA ENERGETICA SL. SecreNoConsj: PEREZ-CRESPO PAYAFRANCISCO. Representan: ELENA DIAZ FERNANDO;MARTIN FERREIRO MARIA DEL AMOR;BARTOLOME PASARO JUAN-MARTIN. Nombramientos. Adm. Unico: ELENA DIAZ FERNANDO. Reelecciones. Auditor: AUDITRUST AUDITORES SLP. Otrosconceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administrador 煤nico. Cambio de objeto social. Eldesarrollo de las siguientes actividades: a) La prestaci贸n de servicios de gesti贸n a empresas p煤blicas y privadas, particulares,comunidades, cooperativas y en general a empresas del sector, interesadas en llevar a cabo la promoci贸n inmobiliaria en todas susfacetas y la venta, arrendamiento .... Datos registrales. T 32766 , F 72, S 8, H M 589783, I/A 8 (14.02.18).
31 de Julio de 2017Revocaciones. Apoderado: MARTIN FERREIRO ANA. Apo.Sol.: BARTOLOME DELICADO JUAN CARLOS. Apo.Manc.:BARTOLOME DELICADO JUAN CARLOS. Apo.Man.Soli: MARTIN FERREIRO MARIA AMOR;RUIBAL FRANCISCO FERNANDO.Nombramientos. Apo.Man.Soli: MARTIN FERREIRO MARIA AMOR;RUIBAL FRANCISCO FERNANDO;MARTIN FERREIROANA;BARTOLOME DELICADO JUAN CARLOS. Datos registrales. T 32766 , F 71, S 8, H M 589783, I/A 7 (21.07.17).
24 de Enero de 2017Revocaciones. Apoderado: ECHAVARREN ZOZAYA GUILLERMO. Nombramientos. Apo.Man.Soli: MARTIN FERREIRO MARIAAMOR;RUIBAL FRANCISCO FERNANDO. Datos registrales. T 32766 , F 70, S 8, H M 589783, I/A 6 (16.01.17).
26 de Mayo de 2016Ceses/Dimisiones. Consejero: MARTIN FERREIRO MARIA AMOR;VARELA DIEZ CARLOS;RUIBAL FRANCISCO FERNANDO.Presidente: MARTIN FERREIRO MARIA AMOR. Con.Delegado: MARTIN FERREIRO MARIA AMOR. Nombramientos. Representan:
Revocaciones. Apoderado: VARELA DIEZ CARLOS. Nombramientos. Apo.Sol.: BARTOLOME DELICADO JUAN CARLOS.Apo.Manc.: BARTOLOME DELICADO JUAN CARLOS. Datos registrales. T 32766 , F 69, S 8, H M 589783, I/A 5 (18.05.16).
30 de Septiembre de 2015Fe de erratas: Se public贸 por error en la Inscripci贸n 3& la P谩gina web corporativa como www.viveme-es, siendo lo correctowww.viveme.es. Datos registrales. T 32766 , F 67, S 8, H M 589783, I/A 3 (17.09.15).