Actos BORME de Vlc Global Sl
19 de Febrero de 2021Cambio de domicilio social. C/ GRABADOR ESTEVE 12 7 (VALENCIA). Datos registrales. T 9439, L 6721, F 54, S 8, H V 147492,I/A 12 (12.02.21).
24 de Abril de 2018Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: PASCUAL LUCAS JULIO;CLIMENT PIQUERAS EMILIO. Nombramientos. Adm. Unico:CLIMENT PIQUERAS EMILIO. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Administradores mancomunados aAdministrador 煤nico. Cambio de domicilio social. AVDA DEL CID 102 Esc.A 2 4 (VALENCIA). Datos registrales. T 9439, L 6721, F54, S 8, H V 147492, I/A 11 (17.04.18).
28 de Noviembre de 2013Revocaciones. Apoderado: SOLER GIMENEZ JUAN CARLOS. Datos registrales. T 9439, L 6721, F 54, S 8, H V 147492, I/A 10(21.11.13).
29 de Abril de 2013Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: PASCUAL LUCAS JULIO. Nombramientos. Adm. Mancom.: PASCUAL LUCAS JULIO;CLIMENTPIQUERAS EMILIO. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n: Administrador 煤nico a Administradoresmancomunados. Datos registrales. T 9439, L 6721, F 53, S 8, H V 147492, I/A 9 (22.04.13).
16 de Abril de 2013Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: SOLER GIMENEZ JUAN CARLOS;SOLER GIMENEZ ALEJANDRO. Nombramientos. Adm. Unico:PASCUAL LUCAS JULIO. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n: Administradores solidarios aAdministrador 煤nico. Datos registrales. T 9439, L 6721, F 53, S 8, H V 147492, I/A 7 ( 9.04.13).
Nombramientos. Apoderado: SOLER GIMENEZ JUAN CARLOS. Datos registrales. T 9439, L 6721, F 53, S 8, H V 147492, I/A 8 (9.04.13).
21 de Marzo de 2013Ceses/Dimisiones. Consejero: CHANZA JORDAN IGNACIO;SOLER GIMENEZ JOSE VICENTE;SOLER GIMENEZ JUANCARLOS;SOLER GIMENEZ ALEJANDRO. Secretario: CHANZA JORDAN IGNACIO. Con.Delegado: SOLER GIMENEZ JUANCARLOS. Presidente: SOLER GIMENEZ JOSE VICENTE. Nombramientos. Adm. Solid.: SOLER GIMENEZ JUAN CARLOS;SOLERGIMENEZ ALEJANDRO. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n aAdministradores solidarios. Datos registrales. T 9439, L 6721, F 52, S 8, H V 147492, I/A 5 (13.03.13).
Revocaciones. Apo.Man.Soli: CHANZA JORDAN IGNACIO;SOLER GIMENEZ ALEJANDRO;SOLER GIMENEZ JOSE VICENTE.Datos registrales. T 9439, L 6721, F 53, S 8, H V 147492, I/A 6 (13.03.13).
12 de Noviembre de 2012Ceses/Dimisiones. Presidente: PASCUAL LUCAS JULIO. Consejero: PASCUAL LUCAS JULIO. Nombramientos. Presidente:SOLER GIMENEZ JOSE VICENTE. Datos registrales. T 9439, L 6721, F 52, S 8, H V 147492, I/A 3 (30.10.12).
Revocaciones. Apo.Man.Soli: PASCUAL LUCAS JULIO. Datos registrales. T 9439, L 6721, F 52, S 8, H V 147492, I/A 4 (30.10.12).
08 de Marzo de 2012Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 7.02.12. Objeto social: La sociedad tendr谩 por objeto: a.- La prestaci贸n de servicios deasesoramiento en materia juridica, financiera, mercantil y comercial. b.- La adquisici贸n, promoci贸n, construcci贸n, venta yarrendamiento, no financiero, de bienes inmuebles, r煤sticos y urbanos por naturaleza. Las actividades integrant. Domicilio: PLAZA DELAYUNTAMIENTO 19 11 C (VALENCIA). Capital: 5.000,00 Euros. Nombramientos. Consejero: PASCUAL LUCAS JULIO;CHANZAJORDAN IGNACIO;SOLER GIMENEZ JOSE VICENTE;SOLER GIMENEZ JUAN CARLOS;SOLER GIMENEZ ALEJANDRO.Presidente: PASCUAL LUCAS JULIO. Secretario: CHANZA JORDAN IGNACIO. Con.Delegado: SOLER GIMENEZ JUAN CARLOS.Datos registrales. T 9439, L 6721, F 50, S 8, H V 147492, I/A 1 (28.02.12).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: SOLER GIMENEZ JOSE VICENTE;PASCUAL LUCAS JULIO;CHANZA JORDAN IGNACIO;SOLERGIMENEZ ALEJANDRO. Datos registrales. T 9439, L 6721, F 51, S 8, H V 147492, I/A 2 (28.02.12).