Actos BORME de Warner Music Spain Sl
22 de Septiembre de 2023Reelecciones. Aud.C.Con.: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 43099 , F 142, S 8, H M 119802, I/A 81 (15.09.23).
06 de Octubre de 2022Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Aud.C.Con.: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 43099 , F 141, S 8, H M119802, I/A 80 (29.09.22).
16 de Marzo de 2022Ceses/Dimisiones. Consejero: DE ZABALA BAZAN I脩IGO. Presidente: DE ZABALA BAZAN I脩IGO. Revocaciones. Apoderado:GONZALEZ AREVALO GUILLERMO;COLE KENNETH EUGENE;GIL ALIAS SUSANA;RAPETTI TIZZE MARIA VALERIA;RUBIOFERNANDEZ MARIA JESUS;BONILLA MARDONES DAVID. Nombramientos. Presidente: ARGOMANIZ BENGOECHEA I脩IGO.Consejero: DUQUE HERNANDEZ ALVARO ALEJANDRO. Apoderado: GONZALEZ AREVALO GUILLERMO;COLE KENNETHEUGENE;GIL ALIAS SUSANA;RAPETTI TIZZE MARIA VALERIA;BONILLA MARDONES DAVID. Modificaciones estatutarias.Art铆culo de los estatutos: 2. Art铆culo de los estatutos: 3. Ampliacion del objeto social. Actividades docentes, acad茅micas y deense帽anza superior. Cambio de domicilio social. CSTA. DE SAN VICENTE 44 - TORRE LEVANTE (MADRID). Datos registrales.T 32390 , F 145, S 8, H M 119802, I/A 79 ( 9.03.22).
26 de Agosto de 2021Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Aud.C.Con.: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 32390 , F 145, S 8, H M119802, I/A 78 (19.08.21).
30 de Diciembre de 2020Nombramientos. Apo.Manc.: COLE KENNETH EUGENE;LORES PEREJOAN CESAR. Datos registrales. T 32390 , F 144, S 8, H M119802, I/A 77 (22.12.20).
31 de Agosto de 2020Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Aud.C.Con.: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 32390 , F 144, S 8, H M119802, I/A 76 (24.08.20).
03 de Agosto de 2020Revocaciones. Apo.Man.Soli: SANCHEZ MORALES JOSE CARLOS;COLE KENNETH EUGENE;GIL ALIAS SUSANA;GONZALEZAREVALO GUILLERMO;RAPETTI TIZZE MARIA VALERIA. Apo.Sol.: RUBIO FERNANDEZ MARIA JESUS. Apo.Manc.: BONILLAMARDONES DAVID. Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ AREVALO GUILLERMO;COLE KENNETH EUGENE;GIL ALIASSUSANA;RAPETTI TIZZE MARIA VALERIA;RUBIO FERNANDEZ MARIA JESUS;BONILLA MARDONES DAVID. Datos registrales.T 32390 , F 142, S 8, H M 119802, I/A 75 (27.07.20).
08 de Julio de 2019Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Aud.C.Con.: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 32390 , F 142, S 8, H M119802, I/A 74 ( 1.07.19).
01 de Julio de 2019Revocaciones. Apoderado: SANCHEZ MORALES JOSE CARLOS;COLE KENNETH EUGENE;GIL ALIAS SUSANA;GONZALEZAREVALO GUILLERMO;RAPETTI TIZZE MARIA VALERIA;RUBIO FERNANDEZ MARIA JESUS. Nombramientos. Apo.Man.Soli:SANCHEZ MORALES JOSE CARLOS;COLE KENNETH EUGENE;GIL ALIAS SUSANA;GONZALEZ AREVALOGUILLERMO;RAPETTI TIZZE MARIA VALERIA. Apo.Sol.: RUBIO FERNANDEZ MARIA JESUS. Apo.Manc.: BONILLA MARDONESDAVID. Datos registrales. T 32390 , F 140, S 8, H M 119802, I/A 73 (24.06.19).
31 de Mayo de 2019Ampliacion del objeto social. La gesti贸n y administraci贸n, mediante la organizaci贸n de los recursos humanos y materialesnecesarios, de valores representativos de los fondos propios de sociedades y otras entidades, sean 茅stas residentes o no en territorioespa帽ol; la inversi贸n en sociedades y otras entidades, sean 茅stas resident. Datos registrales. T 32390 , F 140, S 8, H M 119802, I/A72 (24.05.19).
24 de Octubre de 2018Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Aud.C.Con.: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 32390 , F 139, S 8, H M119802, I/A 70 (15.10.18).
Ceses/Dimisiones. Consejero: SANCHEZ MORALES JOSE CARLOS. Presidente: SANCHEZ MORALES JOSE CARLOS.Consejero: ANCLIFF CHRISTOPHER JOHN. Nombramientos. Consejero: DE ZABALA BAZAN I脩IGO;GONCALVES TEIXEIRAJOAO. Presidente: DE ZABALA BAZAN I脩IGO. Datos registrales. T 32390 , F 140, S 8, H M 119802, I/A 71 (17.10.18).
22 de Febrero de 2018Ceses/Dimisiones. Consejero: DE TORRES ZABALA ALVARO. Nombramientos. Consejero: ARGOMANIZ BENGOECHEA I脩IGO.Datos registrales. T 32390 , F 139, S 8, H M 119802, I/A 69 (13.02.18).
14 de Junio de 2017Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Aud.C.Con.: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 32390 , F 139, S 8, H M119802, I/A 68 ( 5.06.17).
12 de Junio de 2017Modificaciones estatutarias. 16. Organizaci贸n de la administraci贸n de la sociedad.- Modificaci贸n del art铆culo 16潞 de los estatutossociales.. Datos registrales. T 32390 , F 138, S 8, H M 119802, I/A 67 ( 2.06.17).
21 de Marzo de 2017Revocaciones. Apoderado: RODRIGUEZ SAN CIPRIANO PABLO. Datos registrales. T 32390 , F 138, S 8, H M 119802, I/A 66 (9.03.17).
28 de Septiembre de 2016Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Aud.C.Con.: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 32390 , F 137, S 8, H M119802, I/A 64 (20.09.16).
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Aud.C.Con.: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 32390 , F 138, S 8, H M119802, I/A 65 (20.09.16).
24 de Febrero de 2015Ampliacion del objeto social. la fabricaci贸n, compra, venta, importaci贸n, exportaci贸n, reproducci贸n, distribuci贸n, comunicaci贸n
20 de Octubre de 2014Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Aud.C.Con.: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 32390 , F 137, S 8, H M119802, I/A 62 (13.10.14).
14 de Agosto de 2014Revocaciones. Apoderado: SANCHEZ MORALES JOSE CARLOS;COLE KENNETH EUGENE;GIL ALIAS SUSANA;PEREZ GARCIAALFONSO;RAPETTI TIZZE VALERIA;RUBIO FERNANDEZ MARIA JESUS. Nombramientos. Apoderado: SANCHEZ MORALESJOSE CARLOS;COLE KENNETH EUGENE;GIL ALIAS SUSANA;GONZALEZ AREVALO GUILLERMO;RAPETTI TIZZE MARIAVALERIA;RUBIO FERNANDEZ MARIA JESUS;RODRIGUEZ SAN CIPRIANO PABLO. Datos registrales. T 30454 , F 104, S 8, H M119802, I/A 61 ( 7.08.14).
29 de Enero de 2014Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: PARLOPHONE MUSIC SPAIN SL. PARLOPHONE HISPAVOX SL. TRIMECAESTUDIOS Y PRODUCCIONES SL. Datos registrales. T 30454 , F 100, S 8, H M 119802, I/A 60 (20.01.14).
04 de Noviembre de 2013Nombramientos. Aud.C.Con.: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 30454 , F 100, S 8, H M 119802, I/A 58 (24.10.13).
Reelecciones. Aud.C.Con.: ERNST & YOUNG SL. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 30454 , F 100, S 8, H M119802, I/A 59 (24.10.13).
05 de Agosto de 2013Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 30454 , F 100, S 8, H M 119802, I/A 57 (26.07.13).
01 de Febrero de 2013Ceses/Dimisiones. Consejero: REID JOHN DAVID. Nombramientos. Consejero: ANCLIFF CHRISTOPHER JOHN. Datosregistrales. T 19654 , F 204, S 8, H M 119802, I/A 54 (21.01.13).
Ceses/Dimisiones. Consejero: SAUNTER MICHAEL PETER. Nombramientos. Consejero: DE TORRES ZABALA ALVARO. Datosregistrales. T 19654 , F 204, S 8, H M 119802, I/A 55 (22.01.13).
Revocaciones. Apoderado: JAIMEZ LOZANO ANGEL. Datos registrales. T 19654 , F 204, S 8, H M 119802, I/A 56 (22.01.13).
28 de Enero de 2013Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 19654 , F 204, S 8, H M 119802, I/A 53 (18.01.13).
07 de Diciembre de 2010Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 19654 , F 203, S 8, H M 119802, I/A 52 (25.11.10).
01 de Octubre de 2009Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 3,03 Euros. Resultante Suscrito: 150.250,00 Euros. Ampliaci贸n de capital. Capital:364.386,30 Euros. Resultante Suscrito: 514.636,30 Euros. Datos registrales. T 19654 , F 202, S 8, H M 119802, I/A 51 (18.09.09).