Actos BORME de Watsegur Sa
23 de Diciembre de 2021Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: ACACIO COLLADO VICENTE. Representan: VERA VAZQUEZ FRANCISCO. Situaci贸n concursal.
10 de Febrero de 2021Cambio de domicilio social. C/ ORENSE 70 11陋 (MADRID). Datos registrales. T 30700 , F 178, S 8, H M 104190, I/A 79 ( 3.02.21).
21 de Octubre de 2019Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 1197/2017. FIRME: Si, Fecha de resoluci贸n 12/07/2018. Auto de declaraci贸n deconcurso. Voluntario. Juzgado: num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE MADRID. Juez: CARLOS NIETO DELGADO.Resoluciones: Convertida la Anotaci贸n Preventiva letra A de la declaraci贸n de Concurso Voluntario en inscripci贸n, por firmeza del auto.Datos registrales. T 30700 , F 178, S 8, H M 104190, I/A 78 (14.10.19).
31 de Mayo de 2019Revocaciones. Apoderado: ALVAREZ GONZALEZ JUAN ANDRES;ALVAREZ GONZALEZ JUAN ANDRES. Apo.Manc.: ALVAREZGONZALEZ JUAN ANDRES. Datos registrales. T 30700 , F 178, S 8, H M 104190, I/A 77 (24.05.19).
24 de Diciembre de 2018Cambio de domicilio social. AVDA MANOTERAS 18 (MADRID). Datos registrales. T 30700 , F 177, S 8, H M 104190, I/A 76(14.12.18).
02 de Noviembre de 2018Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: REINA PINTO JUAN CARLOS;AVILA ALVAREZ FEDERICO. Nombramientos. Adm. Unico:ACACIO COLLADO VICENTE. Modificaciones estatutarias. apartado 4 del articulo 8, apartado 3 y 4 del articulo 14, apartado 6 delarticulo 15, articulos 16 y 18, apartado 3 y 4 del articulo 19, articulo 20 y 25, apartado 5 del articulo 26, apartado 5 y 6 del articulo 27..Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Administradores mancomunados a Administrador 煤nico. Datos registrales.T 30700 , F 176, S 8, H M 104190, I/A 75 (25.10.18).
24 de Octubre de 2018Nombramientos. Representan: VERA VAZQUEZ FRANCISCO. Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 1197/2017. FIRME:No, Fecha de resoluci贸n 12/07/2018. Auto de declaraci贸n de concurso. Voluntario. Juzgado: num. 1 DE LO MERCANTIL. Juez: DONCARLOS NIETO DELGADO. Resoluciones: La deudora conservar谩 las facultades de administraci贸n y disposici贸n sobre su patrimonio,quedando sometida el ejercicio de 茅stas a la intervenci贸n de la administraci贸n concursal mediante su autorizaci贸n o conformidad.Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 1197/2017. Fecha de resoluci贸n 12/07/2018. Nombramiento de administradores.Juzgado: num. 1 DE LO MERCANTIL. Juez: DON CARLOS NIETO DELGADO. Administrador Concursal. Fecha 12/07/2018, NIF/CIFB65793879. DATA CONCURSAL SLP. Datos registrales. T 30700 , F 175, S 8, H M 104190, I/A A (15.10.18).
09 de Octubre de 2017Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: ENRIQUE BARREIRO NOGALEDO. Nombramientos. Adm. Mancom.: AVILA ALVAREZFEDERICO. Datos registrales. T 30700 , F 175, S 8, H M 104190, I/A 74 (29.09.17).
18 de Abril de 2017Nombramientos. Apoderado: LAYOS PARDO JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 30700 , F 174, S 8, H M 104190, I/A 73 (5.04.17).
20 de Enero de 2017Nombramientos. Apoderado: MEDIANO LORENCI MARIA-YOLANDA. Datos registrales. T 30700 , F 174, S 8, H M 104190, I/A 72(13.01.17).
12 de Septiembre de 2016Nombramientos. Apo.Sol.: FOJO ARIAS LINO HUMBERTO;CASADO MARCOS ESTHER. Datos registrales. T 30700 , F 173, S 8,H M 104190, I/A 70 ( 2.09.16).
Revocaciones. Apo.Sol.: FOJO ARIAS LINO HUMBERTO. Datos registrales. T 30700 , F 173, S 8, H M 104190, I/A 71 ( 2.09.16).
29 de Marzo de 2016Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 30700 , F 173, S 8, H M 104190,I/A 69 (15.03.16).
03 de Noviembre de 2015Nombramientos. Apoderado: REINA TORRES RAMON;RAMIREZ DEL MOLINO ALVARO DELSO;ALVAREZ DIAZ DE CERIOCARLOS;CRUZ CRUZ BEGO脩A;SERRANO SANCHEZ FERNANDO;PEREZ GARCIA MARIA SANDRA. Datos registrales. T 30700, F 172, S 8, H M 104190, I/A 68 (26.10.15).
17 de Septiembre de 2015Ceses/Dimisiones. Consejero: GARCIA MATEOS MANUEL;ALBERTE SENDIN CESAR;ALVAREZ GONZALEZ JUAN ANDRES.Presidente: ALBERTE SENDIN CESAR. Con.Delegado: ALBERTE SENDIN CESAR. SecreNoConsj: GOMEZ MARTINEZ CRISTIAN.Nombramientos. Adm. Mancom.: ENRIQUE BARREIRO NOGALEDO;REINA PINTO JUAN CARLOS. Modificaciones estatutarias.0. Modificaci贸n y nueva redacci贸n de los art铆culos 8, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26 y 27 de los estatutos sociales. .Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administradores mancomunados. Datosregistrales. T 30700 , F 171, S 8, H M 104190, I/A 67 ( 9.09.15).
24 de Abril de 2015Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 30700 , F 170, S 8, H M 104190,I/A 66 (15.04.15).
12 de Mayo de 2014Nombramientos. Apo.Sol.: BENITO RICHARD DAVID;REINA PINTO JUAN CARLOS. Datos registrales. T 30700 , F 170, S 8, H M104190, I/A 65 ( 5.05.14).
21 de Noviembre de 2013Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 30700 , F 170, S 8, H M 104190,I/A 64 (14.11.13).
22 de Abril de 2013Nombramientos. Apoderado: PLAZA MORAN ANGEL. Datos registrales. T 13333 , F 225, S 8, H M 104190, I/A 63 (12.04.13).
06 de Marzo de 2013Nombramientos. Apoderado: LOPEZ PEREZ ROBERTO. Datos registrales. T 13333 , F 225, S 8, H M 104190, I/A 62 (26.02.13).
28 de Noviembre de 2012Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 13333 , F 224, S 8, H M 104190,I/A 61 (15.11.12).
10 de Agosto de 2012Nombramientos. Apoderado: ESCRIBANO MORA ENRIQUE. Datos registrales. T 13333 , F 224, S 8, H M 104190, I/A 60(31.07.12).
07 de Junio de 2012Nombramientos. Apo.Man.Soli: GOMEZ MARTINEZ CRISTIAN. Apo.Manc.: ALBERTE SENDIN CESAR ENRIQUE;ALVAREZGONZALEZ JUAN ANDRES;MARTINEZ BORRALLO ANTONIO;GARCIA MATEOS MANUEL-JOSE;DE EGA脩A HUERTA ALFONSOMIGUEL;VALENZUELA CONTRERAS COSME;SANCHEZ TELLO ANTONIO;CRUZ CRUZ BEGO脩A. Datos registrales. T 13333 , F222, S 8, H M 104190, I/A 59 (28.05.12).
07 de Mayo de 2012Nombramientos. Apoderado: VIDAL GIRON PEDRO. Datos registrales. T 13333 , F 221, S 8, H M 104190, I/A 57 (23.04.12).
Nombramientos. Apoderado: VIDAL GIRON PEDRO. Datos registrales. T 13333 , F 221, S 8, H M 104190, I/A 58 (23.04.12).
04 de Mayo de 2012Revocaciones. Apoderado: ESCRIBANO MORA ENRIQUE. Datos registrales. T 13333 , F 221, S 8, H M 104190, I/A 56 (23.04.12).
09 de Abril de 2012Nombramientos. Apoderado: ALVAREZ GONZALEZ JUAN ANDRES. Datos registrales. T 13333 , F 220, S 8, H M 104190, I/A 55(27.03.12).
04 de Abril de 2012Nombramientos. Apoderado: MARTIN CASTELLO FELIX. Datos registrales. T 13333 , F 220, S 8, H M 104190, I/A 54 (23.03.12).
02 de Abril de 2012Ceses/Dimisiones. Secretario: SALMERON UNTURBE JESUS. Consejero: ESCRIBANO MORA ENRIQUE;CABALLEROFERNANDEZ FERNANDO. Presidente: CABALLERO FERNANDEZ FERNANDO. Con.Delegado: CABALLERO FERNANDEZFERNANDO. Nombramientos. SecreNoConsj: GOMEZ MARTINEZ CRISTIAN. Consejero: ALBERTE SENDIN CESAR;ALVAREZGONZALEZ JUAN ANDRES. Presidente: ALBERTE SENDIN CESAR. Con.Delegado: ALBERTE SENDIN CESAR. Datos registrales.T 13333 , F 220, S 8, H M 104190, I/A 53 (22.03.12).
30 de Marzo de 2012Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 13333 , F 171, S 8, H M 104190,I/A 52 (21.03.12).
17 de Enero de 2012Nombramientos. Apoderado: GOMEZ MARTINEZ CRISTIAN. Datos registrales. T 13333 , F 171, S 8, H M 104190, I/A 51 (4.01.12).
10 de Enero de 2012Nombramientos. Apoderado: ESCRIBANO MORA ENRIQUE. Datos registrales. T 13333 , F 171, S 8, H M 104190, I/A 50(29.12.11).
08 de Noviembre de 2011Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ LARRAD DANIEL EUSEBIO. Datos registrales. T 13333 , F 171, S 8, H M 104190, I/A 49(26.10.11).
26 de Mayo de 2011Revocaciones. Apoderado: AVILA ALVAREZ FEDERICO. Datos registrales. T 13333 , F 170, S 8, H M 104190, I/A 47 (13.05.11).
Nombramientos. Apoderado: ALVAREZ GONZALEZ JUAN ANDRES. Datos registrales. T 13333 , F 170, S 8, H M 104190, I/A 48(13.05.11).
28 de Febrero de 2011Nombramientos. Apoderado: MARTIN CASTELLO FELIX. Datos registrales. T 13333 , F 169, S 8, H M 104190, I/A 46 (16.02.11).
24 de Febrero de 2011Nombramientos. Apoderado: SANCHEZ SANZ MARIA. Datos registrales. T 13333 , F 169, S 8, H M 104190, I/A 45 (11.02.11).
16 de Febrero de 2011Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 13333 , F 169, S 8, H M 104190,I/A 44 (27.01.11).
11 de Octubre de 2010Nombramientos. Apoderado: LAYOS PARDO JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 13333 , F 168, S 8, H M 104190, I/A 43(29.09.10).
13 de Septiembre de 2010Reelecciones. Consejero: ESCRIBANO MORA ENRIQUE;CABALLERO FERNANDEZ FERNANDO. Presidente: CABALLEROFERNANDEZ FERNANDO. Con.Delegado: CABALLERO FERNANDEZ FERNANDO. Consejero: GARCIA MATEOS MANUEL. Datosregistrales. T 13333 , F 168, S 8, H M 104190, I/A 42 ( 1.09.10).
04 de Febrero de 2010Revocaciones. Apoderado: ARCE AMEZCUA MANUEL;PRIETO MORALEJO LUIS. Datos registrales. T 13333 , F 168, S 8, H M104190, I/A 41 (25.01.10).
13 de Noviembre de 2009Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 13333 , F 168, S 8, H M 104190,I/A 40 ( 2.11.09).
28 de Abril de 2009Nombramientos. Apo.Man.Soli: VALENZUELA CONTRERAS COSME;SANCHEZ TELLO ANTONIO. Datos registrales. T 13333 , F167, S 8, H M 104190, I/A 39 (16.04.09).
25 de Febrero de 2009Nombramientos. Apoderado: AVILA ALVAREZ FEDERICO. Datos registrales. T 13333 , F 166, S 8, H M 104190, I/A 38 (14.02.09).
09 de Febrero de 2009Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 13333 , F 166, S 8, H M 104190,I/A 37 (28.01.09).