Buscador CIF Logo

Actos BORME Watts Ind Iberica Sa

¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Watts Ind Iberica Sa

Actos BORME Watts Ind Iberica Sa - A58811431

Tenemos registrados 23 Actos BORME del Registro Mercantil de Barcelona para Watts Ind Iberica Sa con CIF A58811431

🔙 Perfil de Watts Ind Iberica Sa
🛒 Comprar listado completo de Empresas de Barcelona

Actos BORME de Watts Ind Iberica Sa

24 de Julio de 2023
Cancelaciones de oficio de nombramientos. CONSEJERO: ANTHONIUS JOHANNES PHILIPPUS HAITSMA. PRESIDENTE:ANTHONIUS JOHANNES PHILIPPUS HAITSMA. CONSEJERO: OLIVIER PAUL JEAN GIVERDON. VICEPRESIDEN: OLIVIER PAULJEAN GIVERDON. Datos registrales. T 42974 , F 146, S 8, H B 86191, I/A 44 N (26.06.23).

08 de Enero de 2021
Cancelaciones de oficio de nombramientos. CONSEJERO: ROBERTO MORA. Datos registrales. T 42974 , F 143, S 8, H B86191, I/A 39 N (28.12.20).

16 de Noviembre de 2016
Revocaciones. CONSEJERO: MARIO SANCHEZ. PRESIDENTE: MARIO SANCHEZ. CONSEJERO: CORNELIS HENDRIK PRUIM.VICEPRESIDEN: CORNELIS HENDRIK PRUIM. Nombramientos. CONSEJERO: ANTHONIUS JOHANNES PHILIPPUS HAITSMA.PRESIDENTE: ANTHONIUS JOHANNES PHILIPPUS HAITSMA. CONSEJERO: OLIVIER PAUL JEAN GIVERDON. VICEPRESIDEN:OLIVIER PAUL JEAN GIVERDON. Datos registrales. T 42974 , F 146, S 8, H B 86191, I/A 44 ( 7.11.16).

29 de Julio de 2016
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 42974 , F 145, S 8, H B 86191, I/A 43 (21.07.16).

17 de Junio de 2015
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 42974 , F 145, S 8, H B 86191, I/A 42 ( 9.06.15).

23 de Diciembre de 2014
Revocaciones. APOD.CONJUN.: UMBERTO FERRETI;ROBERTO MORA;MESTRES GOMEZ BENVINGUT;MARTINEZRODRIGUEZ CONCEPCION. APODERAD.SOL: CANELA ALONSO JORGE JOSE. Nombramientos. APOD.MANCOMU: MESTRESGOMEZ BENVINGUT;ROBERTO MORA;ROCA DEU LAURA. Datos registrales. T 42974 , F 143, S 8, H B 86191, I/A 41 (16.12.14).

12 de Septiembre de 2014
Otros conceptos: CONSTANCIA DEL CAMBIO DE DENOMINACION SOCIAL DEL SOCIO UNICO, EN ADELANTE: "WATTSWATER TECHNOLOGIES EMEA BV". Datos registrales. T 42974 , F 143, S 8, H B 86191, I/A 40 ( 5.09.14).

02 de Septiembre de 2014
Revocaciones. CONSEJERO: CANELA ALONSO JORGE JOSE. CONS. DELEG.: CANELA ALONSO JORGE JOSE.Nombramientos. CONSEJERO: ROBERTO MORA. APODERAD.SOL: CANELA ALONSO JORGE JOSE. Datos registrales. T42974 , F 143, S 8, H B 86191, I/A 39 (25.08.14).

30 de Abril de 2014
Revocaciones. CONSEJERO: UMBERTO FERRETTI. Datos registrales. T 42974 , F 142, S 8, H B 86191, I/A 37 (23.04.14).

Nombramientos. APODERAD.SOL: ARENTIUS JACOBUS STOKKEL. Datos registrales. T 42974 , F 143, S 8, H B 86191, I/A 38(23.04.14).

11 de Abril de 2014
Revocaciones. CONSEJERO: JOHN DENNIS CAWTE. PRESIDENTE: JOHN DENNIS CAWTE. VICEPRESIDEN: CANELA ALONSOJORGE JOSE. Nombramientos. CONSEJERO: MARIO SANCHEZ. PRESIDENTE: MARIO SANCHEZ. CONSEJERO: CORNELISHENDRIK PRUIM. VICEPRESIDEN: CORNELIS HENDRIK PRUIM. Datos registrales. T 42974 , F 142, S 8, H B 86191, I/A 36 (2.04.14).

09 de Diciembre de 2013
Revocaciones. CONSEJERO: ALEXANDER SEBASTIAN KIESOUW. VICEPRESIDEN: ALEXANDER SEBASTIAN KIESOUW.Nombramientos. VICEPRESIDEN: CANELA ALONSO JORGE JOSE. Datos registrales. T 42974 , F 142, S 8, H B 86191, I/A 35(28.11.13).

20 de Junio de 2013
Revocaciones. APODERADO: UMBERTO FERRETI;ROBERTO MORA;MESTRES GOMEZ BENVINGUT;MARTINEZ RODRIGUEZCONCEPCION. Nombramientos. APOD.CONJUN.: UMBERTO FERRETI;ROBERTO MORA;MESTRES GOMEZBENVINGUT;MARTINEZ RODRIGUEZ CONCEPCION. Datos registrales. T 42974 , F 142, S 8, H B 86191, I/A 34 (12.06.13).

07 de Mayo de 2013
Nombramientos. CONSEJERO: CANELA ALONSO JORGE JOSE. CONS. DELEG.: CANELA ALONSO JORGE JOSE. Datosregistrales. T 42974 , F 141, S 8, H B 86191, I/A 33 (25.04.13).

31 de Enero de 2012
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 42974 , F 141, S 8, H B 86191, I/A 32 (19.01.12).

16 de Enero de 2012
Nombramientos. CONSEJERO: JOHN DENNIS CAWTE. PRESIDENTE: JOHN DENNIS CAWTE. CONSEJERO: UMBERTOFERRETTI. Datos registrales. T 42974 , F 141, S 8, H B 86191, I/A 30 ( 4.01.12).

Revocaciones. APODERADO: BATLLE MOLINA EMILIO. Datos registrales. T 42974 , F 141, S 8, H B 86191, I/A 31 ( 4.01.12).

20 de Abril de 2011
Nombramientos. APODERADO: UMBERTO FERRETI;ROBERTO MORA;MESTRES GOMEZ BENVINGUT;MARTINEZRODRIGUEZ CONCEPCION. Datos registrales. T 25233 , F 19, S 8, H B 86191, I/A 29 ( 7.04.11).

Nombramientos. AUDIT.CUENT.: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 25233 , F 19, S 8, H B 86191, I/A 28 ( 7.04.11).

07 de Febrero de 2011
Revocaciones. APODERADO: JOHAN VAN KOUTERIK. Datos registrales. T 25233 , F 19, S 8, H B 86191, I/A 27 (25.01.11).

16 de Agosto de 2010
Revocaciones. CONSEJERO: JOHAN VAN KOUTERIK. PRESIDENTE: JOHAN VAN KOUTERIK. VICEPRESIDEN: CANELAALONSO JORGE JOSE. Nombramientos. CONSEJERO: ALEXANDER SEBASTIAN KIESOUW. VICEPRESIDEN: ALEXANDERSEBASTIAN KIESOUW. PRESIDENTE: JOHN DENNIS CAWTE. Datos registrales. T 25233 , F 18, S 8, H B 86191, I/A 26 ( 4.08.10).

Nombramientos. AUDIT.CUENT.: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 25233 , F 18, S 8, H B 86191, I/A 25 ( 4.08.10).

30 de Marzo de 2009
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 25233 , F 18, S 8, H B 86191, I/A 24 (16.03.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información