Buscador CIF Logo

Actos BORME Way Atalaya Sl

¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Way Atalaya Sl

Actos BORME Way Atalaya Sl - B81771628

Tenemos registrados 18 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Way Atalaya Sl con CIF B81771628

🔙 Perfil de Way Atalaya Sl
🛒 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Way Atalaya Sl

16 de Noviembre de 2023
Revocaciones. Apoderado: GARCIA DE LEANIZ CANOSA IGNACIO CESAR. Datos registrales. T 39132 , F 126, S 8, H M 195178,I/A 31 ( 8.11.23).

05 de Abril de 2023
Nombramientos. Apoderado: LOPEZ CANUTO MARIA ELENA. Datos registrales. T 39132 , F 124, S 8, H M 195178, I/A 30(29.03.23).

13 de Septiembre de 2021
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 39132 , F 124, S 8, H M 195178, I/A 29 ( 6.09.21).

07 de Junio de 2021
Nombramientos. Apoderado: GARCIA DE LEANIZ CANOSA IGNACIO CESAR. Datos registrales. T 39132 , F 122, S 8, H M195178, I/A 28 (31.05.21).

04 de Febrero de 2020
Revocaciones. Apo.Man.Soli: MORENO GARCIA JOSE ANTONIO;FERNANDEZ OJEDA ELOY. Datos registrales. T 39132 , F 122,S 8, H M 195178, I/A 27 (28.01.20).

24 de Junio de 2019
Nombramientos. Apo.Man.Soli: GONZALEZ BRAVO SERGIO;MORENO GARCIA JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 32596 , F49, S 8, H M 195178, I/A 26 (17.06.19).

31 de Diciembre de 2018
Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 32596 , F 49, S 8, H M 195178, I/A 25 (21.12.18).

03 de Diciembre de 2018
Nombramientos. Auditor: AUDIJURIS AUDITORES CONSULTORES SL. Datos registrales. T 32596 , F 49, S 8, H M 195178, I/A24 (23.11.18).

10 de Septiembre de 2018
Nombramientos. Apoderado: TRIGUEROS RODRIGUEZ ALBERTO. Datos registrales. T 32596 , F 48, S 8, H M 195178, I/A 23(27.08.18).

23 de Enero de 2018
Modificaciones estatutarias. REFUNDICION DE LOS ESTATUTOS. Datos registrales. T 32596 , F 45, S 8, H M 195178, I/A 22(15.01.18).

22 de Enero de 2018
Nombramientos. VsecrNoConsj: MANTECA MARTINEZ MONICA. Datos registrales. T 32596 , F 45, S 8, H M 195178, I/A 21(12.01.18).

27 de Enero de 2017
Nombramientos. Apoderado: DOMINGUEZ RODRIGUEZ LUIS ALBERTO;PEREZ MARTINEZ JOSE MANUEL;MORENO PAGEESPERANZA;BERRON CANTADOR MIRIAM;LOPEZ SANCHEZ PILAR;MUÑOZ MOYA LAURA;SIMARRO MOYA MARIAJOSE;GARCIA ROSADO ROSA;TRIGUEROS RODRIGUEZ ALBERTO. Datos registrales. T 32596 , F 42, S 8, H M 195178, I/A 20(19.01.17).

22 de Abril de 2015
Revocaciones. Apoderado: GALAN CALLE JESUS GABRIEL;MARTINEZ ESTEBAN CARMELO;LOPEZ TORRALBA FLORENTINOJESUS. Datos registrales. T 32596 , F 40, S 8, H M 195178, I/A 18 (15.04.15).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: MORENO GARCIA JOSE ANTONIO;FERNANDEZ OJEDA ELOY. Datos registrales. T 32596 , F40, S 8, H M 195178, I/A 19 (15.04.15).

20 de Abril de 2015
Ceses/Dimisiones. Representan: LOPEZ TORRALBA FLORENTINO JESUS. Nombramientos. Representan: ALONSO SOROAVALENTIN. Datos registrales. T 32596 , F 40, S 8, H M 195178, I/A 17 (10.04.15).

21 de Octubre de 2014
Revocaciones. Apoderado: GALAN CALLE JESUS GABRIEL. Datos registrales. T 12305 , F 43, S 8, H M 195178, I/A 16(14.10.14).

16 de Marzo de 2010
Nombramientos. Apoderado: CALVO PUJOL JUAN JOSE;LOPEZ TORRALBA FLORENTINO JESUS;GALAN CALLE JESUSGABRIEL. Datos registrales. T 12305 , F 42, S 8, H M 195178, I/A 15 ( 5.03.10).

31 de Marzo de 2009
Cambio de domicilio social. C/ MENDEZ ALVARO, 83, - ESTACION SUR DE AUTOBUSES (MADRID). Datos registrales. T 12305, F 42, S 8, H M 195178, I/A 14 (20.03.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información