Buscador CIF Logo

Actos BORME Wellcome Farmaceutica Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Wellcome Farmaceutica Sa

Actos BORME Wellcome Farmaceutica Sa - A28032530

Tenemos registrados 22 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Wellcome Farmaceutica Sa con CIF A28032530

馃敊 Perfil de Wellcome Farmaceutica Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Wellcome Farmaceutica Sa

02 de Julio de 2012
Disoluci贸n. Fusion. Extinci贸n. Datos registrales. T 25275 , F 186, S 8, H M 49012, I/A 161 (20.06.12).

21 de Junio de 2012
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 25275 , F 186, S 8, H M 49012, I/A159 (12.06.12).

Reelecciones. Consejero: PEREZ SANTOS JUAN MANUEL. Datos registrales. T 25275 , F 186, S 8, H M 49012, I/A 160(12.06.12).

15 de Diciembre de 2011
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 25275 , F 186, S 8, H M 49012, I/A158 ( 2.12.11).

13 de Septiembre de 2011
Reelecciones. Secretario: COLLDEFORS MARTINEZ JOSE MIGUEL. Consejero: COLLDEFORS MARTINEZ JOSE MIGUEL. Datosregistrales. T 25275 , F 185, S 8, H M 49012, I/A 156 (31.08.11).

Revocaciones. Apoderado: MU脩OZ FUENTES JORGE. Nombramientos. Apo.Sol.: MARIN GALLARDO CONCEPCIONJULIA;GARCIA-SOTO RETUERTA ROBERTO. Datos registrales. T 25275 , F 185, S 8, H M 49012, I/A 157 (31.08.11).

11 de Julio de 2011
Revocaciones. Apoderado: MU脩OZ FUENTES JORGE. Nombramientos. Apo.Sol.: PELAEZ DELGADO SILVIA. Datosregistrales. T 25275 , F 184, S 8, H M 49012, I/A 155 (29.06.11).

04 de Marzo de 2011
Revocaciones. Apoderado: PORTAL MARTINEZ PERFECTO;PORTAL MARTINEZ PERFECTO. Apo.Manc.: PORTAL MARTINEZPERFECTO. Apoderado: PORTAL MARTINEZ PERFECTO. Nombramientos. Apoderado: MORALES MENENDEZ EVA;BECKERRUDIGER;PORTAL MARTINEZ PERFECTO;PEREZ SANTOS JUAN MANUEL;DIAZ GOMEZ MARIA ELISA;MORALES MENENDEZEVA;BECKER RUDIGER;COLLDEFORS MARTINEZ JOSE MIGUEL;PORTAL MARTINEZ PERFECTO;PEREZ SANTOS JUANMANUEL;RAMOS GAYTAN EDUARDO;PARIS VICENTE GONZALO;DIAZ GOMEZ MARIA ELISA;MORALES MENENDEZEVA;BECKER RUDIGER;PORTAL MARTINEZ PERFECTO;PEREZ SANTOS JUAN MANUEL;DIAZ GOMEZ MARIA ELISA;GOMEZFERNANDEZ CONSUELO;PELAEZ DELGADO SILVIA;BECKER RUDIGER;COLLDEFORS MARTINEZ JOSE MIGUEL;FERNANDEZGONZALEZ CRISTINA;PEREZ SANTOS JUAN MANUEL;PORTAL MARTINEZ PERFECTO. Datos registrales. T 25275 , F 183, S 8,H M 49012, I/A 154 (23.02.11).

26 de Noviembre de 2010
Revocaciones. Apoderado: CARDONIGA MAO JOSE;TARRIZA MARTINEZ JOSE;CADORNIGA MAO JOSE;CADORNIGA MAOJOSE;CADORNIGA MAO JOSE;TARRIZA MARTINEZ JOSE. Nombramientos. Apo.Sol.: PEREZ ALVARO MARIA DEL VAL. Datosregistrales. T 25275 , F 182, S 8, H M 49012, I/A 152 (17.11.10).

Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 25275 , F 182, S 8, H M 49012, I/A153 (17.11.10).

26 de Octubre de 2010
Nombramientos. Apoderado: NU脩EZ JARAMILLO ALICIA;PEREZ DOMINGUEZ ANA FLORA. Datos registrales. T 25275 , F 181,S 8, H M 49012, I/A 151 (13.10.10).

14 de Octubre de 2010
Nombramientos. Apoderado: CHILVER-STAINER SARAH JANE. Datos registrales. T 25275 , F 180, S 8, H M 49012, I/A 150(30.09.10).

30 de Julio de 2010
Reelecciones. Consejero: PARIS VICENTE GONZALO. Datos registrales. T 25275 , F 179, S 8, H M 49012, I/A 148 (20.07.10).

Revocaciones. Apoderado: DE PRADO GARCIA SUSANA;DE PRADO GARCIA SUSANA;DE PRADO GARCIA SUSANA.Nombramientos. Apoderado: FERRE REVUELTA MERCEDES. Datos registrales. T 25275 , F 180, S 8, H M 49012, I/A 149(20.07.10).

27 de Enero de 2010
Revocaciones. Apoderado: MARTIN BOADO ANA MARIA. Nombramientos. Apoderado: ORTEGA BASAGOITI RAFAEL;PORTALMARTINEZ PERFECTO;FERNANDEZ GONZALEZ CRISTINA;CARDENAL IRADIER MARIA. Datos registrales. T 25275 , F 178, S8, H M 49012, I/A 147 (15.01.10).

15 de Diciembre de 2009
Revocaciones. Apoderado: DAL-RE SAAVEDRA RAFAEL;DAL-RE SAAVEDRA RAFAEL. Datos registrales. T 25275 , F 178, S 8,H M 49012, I/A 146 ( 1.12.09).

23 de Noviembre de 2009
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 25275 , F 178, S 8, H M 49012, I/A145 (11.11.09).

17 de Agosto de 2009
Revocaciones. Apoderado: LUZ MORENO JUAN PEDRO;FERRERO LOPEZ RAFAEL;FERRERO LOPEZ RAFAEL;FERREROLOPEZ RAFAEL;LUZ MORENO JUAN PEDRO. Nombramientos. Apoderado: DIAZ GOMEZ MARIA ELISA;GOMEZ FERNANDEZCONSUELO. Datos registrales. T 25275 , F 177, S 8, H M 49012, I/A 144 ( 5.08.09).

22 de Junio de 2009
Nombramientos. Apoderado: DIAZ GOMEZ MARIA ELISA. Datos registrales. T 25275 , F 176, S 8, H M 49012, I/A 142 (10.06.09).

Nombramientos. Apoderado: DIAZ GOMEZ MARIA ELISA;JIMENEZ COLETO JOSEFA;CALVO ALONSO DANIEL;DE PRADOGARCIA SUSANA;TARRIZA MARTINEZ JOSE;REDONDO NIETO JULIAN;PARIS VICENTE GONZALO;PEREZ ESCOLANO ISABEL.Datos registrales. T 25275 , F 176, S 8, H M 49012, I/A 143 (10.06.09).

26 de Marzo de 2009
Revocaciones. Apoderado: LAGUNA MENA JOSE LUIS. Datos registrales. T 25275 , F 176, S 8, H M 49012, I/A 141 (16.03.09).

03 de Marzo de 2009
Nombramientos. Apoderado: COLLDEFORS MARTINEZ JOSE MIGUEL;PEREZ SANTOS JUAN MANUEL. Datos registrales. T25275 , F 176, S 8, H M 49012, I/A 140 (20.02.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n