Actos BORME de Wellcome Farmaceutica Sa
02 de Julio de 2012Disoluci贸n. Fusion. Extinci贸n. Datos registrales. T 25275 , F 186, S 8, H M 49012, I/A 161 (20.06.12).
21 de Junio de 2012Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 25275 , F 186, S 8, H M 49012, I/A159 (12.06.12).
Reelecciones. Consejero: PEREZ SANTOS JUAN MANUEL. Datos registrales. T 25275 , F 186, S 8, H M 49012, I/A 160(12.06.12).
15 de Diciembre de 2011Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 25275 , F 186, S 8, H M 49012, I/A158 ( 2.12.11).
13 de Septiembre de 2011Reelecciones. Secretario: COLLDEFORS MARTINEZ JOSE MIGUEL. Consejero: COLLDEFORS MARTINEZ JOSE MIGUEL. Datosregistrales. T 25275 , F 185, S 8, H M 49012, I/A 156 (31.08.11).
Revocaciones. Apoderado: MU脩OZ FUENTES JORGE. Nombramientos. Apo.Sol.: MARIN GALLARDO CONCEPCIONJULIA;GARCIA-SOTO RETUERTA ROBERTO. Datos registrales. T 25275 , F 185, S 8, H M 49012, I/A 157 (31.08.11).
11 de Julio de 2011Revocaciones. Apoderado: MU脩OZ FUENTES JORGE. Nombramientos. Apo.Sol.: PELAEZ DELGADO SILVIA. Datosregistrales. T 25275 , F 184, S 8, H M 49012, I/A 155 (29.06.11).
04 de Marzo de 2011Revocaciones. Apoderado: PORTAL MARTINEZ PERFECTO;PORTAL MARTINEZ PERFECTO. Apo.Manc.: PORTAL MARTINEZPERFECTO. Apoderado: PORTAL MARTINEZ PERFECTO. Nombramientos. Apoderado: MORALES MENENDEZ EVA;BECKERRUDIGER;PORTAL MARTINEZ PERFECTO;PEREZ SANTOS JUAN MANUEL;DIAZ GOMEZ MARIA ELISA;MORALES MENENDEZEVA;BECKER RUDIGER;COLLDEFORS MARTINEZ JOSE MIGUEL;PORTAL MARTINEZ PERFECTO;PEREZ SANTOS JUANMANUEL;RAMOS GAYTAN EDUARDO;PARIS VICENTE GONZALO;DIAZ GOMEZ MARIA ELISA;MORALES MENENDEZEVA;BECKER RUDIGER;PORTAL MARTINEZ PERFECTO;PEREZ SANTOS JUAN MANUEL;DIAZ GOMEZ MARIA ELISA;GOMEZFERNANDEZ CONSUELO;PELAEZ DELGADO SILVIA;BECKER RUDIGER;COLLDEFORS MARTINEZ JOSE MIGUEL;FERNANDEZGONZALEZ CRISTINA;PEREZ SANTOS JUAN MANUEL;PORTAL MARTINEZ PERFECTO. Datos registrales. T 25275 , F 183, S 8,H M 49012, I/A 154 (23.02.11).
26 de Noviembre de 2010Revocaciones. Apoderado: CARDONIGA MAO JOSE;TARRIZA MARTINEZ JOSE;CADORNIGA MAO JOSE;CADORNIGA MAOJOSE;CADORNIGA MAO JOSE;TARRIZA MARTINEZ JOSE. Nombramientos. Apo.Sol.: PEREZ ALVARO MARIA DEL VAL. Datosregistrales. T 25275 , F 182, S 8, H M 49012, I/A 152 (17.11.10).
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 25275 , F 182, S 8, H M 49012, I/A153 (17.11.10).
26 de Octubre de 2010Nombramientos. Apoderado: NU脩EZ JARAMILLO ALICIA;PEREZ DOMINGUEZ ANA FLORA. Datos registrales. T 25275 , F 181,S 8, H M 49012, I/A 151 (13.10.10).
14 de Octubre de 2010Nombramientos. Apoderado: CHILVER-STAINER SARAH JANE. Datos registrales. T 25275 , F 180, S 8, H M 49012, I/A 150(30.09.10).
30 de Julio de 2010Reelecciones. Consejero: PARIS VICENTE GONZALO. Datos registrales. T 25275 , F 179, S 8, H M 49012, I/A 148 (20.07.10).
Revocaciones. Apoderado: DE PRADO GARCIA SUSANA;DE PRADO GARCIA SUSANA;DE PRADO GARCIA SUSANA.Nombramientos. Apoderado: FERRE REVUELTA MERCEDES. Datos registrales. T 25275 , F 180, S 8, H M 49012, I/A 149(20.07.10).
27 de Enero de 2010Revocaciones. Apoderado: MARTIN BOADO ANA MARIA. Nombramientos. Apoderado: ORTEGA BASAGOITI RAFAEL;PORTALMARTINEZ PERFECTO;FERNANDEZ GONZALEZ CRISTINA;CARDENAL IRADIER MARIA. Datos registrales. T 25275 , F 178, S8, H M 49012, I/A 147 (15.01.10).
15 de Diciembre de 2009Revocaciones. Apoderado: DAL-RE SAAVEDRA RAFAEL;DAL-RE SAAVEDRA RAFAEL. Datos registrales. T 25275 , F 178, S 8,H M 49012, I/A 146 ( 1.12.09).
23 de Noviembre de 2009Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 25275 , F 178, S 8, H M 49012, I/A145 (11.11.09).
17 de Agosto de 2009Revocaciones. Apoderado: LUZ MORENO JUAN PEDRO;FERRERO LOPEZ RAFAEL;FERRERO LOPEZ RAFAEL;FERREROLOPEZ RAFAEL;LUZ MORENO JUAN PEDRO. Nombramientos. Apoderado: DIAZ GOMEZ MARIA ELISA;GOMEZ FERNANDEZCONSUELO. Datos registrales. T 25275 , F 177, S 8, H M 49012, I/A 144 ( 5.08.09).
22 de Junio de 2009Nombramientos. Apoderado: DIAZ GOMEZ MARIA ELISA. Datos registrales. T 25275 , F 176, S 8, H M 49012, I/A 142 (10.06.09).
Nombramientos. Apoderado: DIAZ GOMEZ MARIA ELISA;JIMENEZ COLETO JOSEFA;CALVO ALONSO DANIEL;DE PRADOGARCIA SUSANA;TARRIZA MARTINEZ JOSE;REDONDO NIETO JULIAN;PARIS VICENTE GONZALO;PEREZ ESCOLANO ISABEL.Datos registrales. T 25275 , F 176, S 8, H M 49012, I/A 143 (10.06.09).
26 de Marzo de 2009Revocaciones. Apoderado: LAGUNA MENA JOSE LUIS. Datos registrales. T 25275 , F 176, S 8, H M 49012, I/A 141 (16.03.09).
03 de Marzo de 2009Nombramientos. Apoderado: COLLDEFORS MARTINEZ JOSE MIGUEL;PEREZ SANTOS JUAN MANUEL. Datos registrales. T25275 , F 176, S 8, H M 49012, I/A 140 (20.02.09).