Buscador CIF Logo

Actos BORME Westrock Packaging Systems Spain Sociedad Limitada

¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Westrock Packaging Systems Spain Sociedad Limitada

Actos BORME Westrock Packaging Systems Spain Sociedad Limitada - B48029672

Tenemos registrados 11 Actos BORME del Registro Mercantil de Vizcaya para Westrock Packaging Systems Spain Sociedad Limitada con CIF B48029672

🔙 Perfil de Westrock Packaging Systems Spain Sociedad Limitada
🛒 Comprar listado completo de Empresas de Vizcaya

Actos BORME de Westrock Packaging Systems Spain Sociedad Limitada

13 de Octubre de 2023
Revocaciones. Apoderado: BONILLA MARTINEZ MONICA. Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ ANTOLINALVARO;GONZALEZ MARTIN ASIER. Datos registrales. T 5786 , F 35, S 8, H BI 563,A , I/ 88 .( 4.10.23).

28 de Agosto de 2023
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 5786 , F 35, S 8, H BI 563,A , I/ 87.(17.08.23).

07 de Julio de 2021
Revocaciones. Apoderado: NISTAL PEREZ FRANCISCO;FERNANDEZ ANTOLIN ALVARO;GONZALEZ MARTIN ASIER;BONILLAMARTINEZ MONICA;ZULUAGA URIBASTERRA MARIA NEREA. Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ ANTOLINALVARO;GONZALEZ MARTIN ASIER;BONILLA MARTINEZ MONICA;ZULUAGA URIBASTERRA MARIA NEREA;RICO CABRERALEIRE;SAN JUAN RODRIGUEZ BEGOÑA. Datos registrales. T 5786 , F 34, S 8, H BI 563,A , I/ 86 .(29.06.21).

27 de Julio de 2020
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 5786 , F 34, S 8, H BI 563,A , I/ 85.(21.07.20).

18 de Marzo de 2019
Revocaciones. Apoderado: SANCHEZ SANTACOLOMA LUIS CARLOS;FERNANDEZ ANTOLIN ALVARO;GONZALEZ MARTINASIER;ESLAVA GONZALEZ ALVARO;BONILLA MARTINEZ MONICA;ZULUAGA URIBASTERRA MARIA NEREA. Nombramientos.Apoderado: FERNANDEZ ANTOLIN ALVARO;GONZALEZ MARTIN ASIER;BONILLA MARTINEZ MONICA;ZULUAGA URIBASTERRAMARIA NEREA;NISTAL PEREZ FRANCISCO. Datos registrales. T 5786 , F 33, S 8, H BI 563,A , I/ 84 .( 7.03.19).

22 de Junio de 2018
Revocaciones. Apoderado: SANCHEZ SANTACOLOMA LUIS CARLOS;GONZALEZ MARTIN ASIER;FERNANDEZ ANTOLINALVARO;BONILLA MARTINEZ MONICA. Nombramientos. Apoderado: SANCHEZ SANTACOLOMA LUIS CARLOS;FERNANDEZANTOLIN ALVARO;GONZALEZ MARTIN ASIER;ESLAVA GONZALEZ ALVARO;BONILLA MARTINEZ MONICA;ZULUAGAURIBASTERRA MARIA NEREA. Datos registrales. T 5401 , F 75, S 8, H BI 563,A , I/ 82 .(14.06.18).

Nombramientos. Auditor: ERNST & YOUNG SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 5786 , F 33, S 8, H BI 563,A , I/ 83.(15.06.18).

22 de Febrero de 2017
Revocaciones. Apoderado: ALONSO GARCIA SILVIA. Datos registrales. T 5401 , F 76, S 8, H BI 563,A , I/ 81 .(15.02.17).

16 de Febrero de 2017
Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: SMITH RAL ZACHRY. Datos registrales. T 5401 , F 75, S 8, H BI 563,A , I/ 80 .( 1.02.17).

02 de Enero de 2017
Ceses/Dimisiones. Apoderado: CAMINO FARRE EVA. Datos registrales. T 5401 , F 74, S 8, H BI 563,A , I/ 79 .(21.12.16).

22 de Diciembre de 2016
Nombramientos. Apoderado: SANCHEZ SANTACOLOMA LUIS CARLOS;GONZALEZ MARTIN ASIER;FERNANDEZ ANTOLINALVARO;BONILLA MARTINEZ MONICA;ALONSO GARCIA SILVIA. Datos registrales. T 5401 , F 74, S 8, H BI 563,A , I/ 78 .(7.12.16).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información