Actos BORME de Wfc Spain 2 Sl
10 de Noviembre de 2023Revocaciones. Apo.Sol.: GONZALEZ CARRAMI脩ANA ALVARO. Nombramientos. Apoderado: PARDO CALLEJA LETICIA. Datos
13 de Junio de 2022Revocaciones. Apoderado: CARRASCO GARCIA PAULA. Nombramientos. Apo.Sol.: GONZALEZ CARRAMI脩ANA ALVARO.Datos registrales. T 40435 , F 2, S 8, H M 669668, I/A 16 ( 6.06.22).
30 de Octubre de 2020Otros conceptos: CAMBIO DE DENOMINACION DEL SOCIO UNICO QUE PASA DE "THOMAS COOK HOTEL INVESTMENTSLIMITED" POR LA DE "WESTFORT CAPITAL LIMITED". Datos registrales. T 40435 , F 2, S 8, H M 669668, I/A 15 (23.10.20).
24 de Septiembre de 2020Modificaciones estatutarias. Modificaci贸n del art铆culo 10 de los estatutos. Modificaci贸n del art铆culo 8 de los estatutos. Datosregistrales. T 40435 , F 1, S 8, H M 669668, I/A 14 (17.09.20).
03 de Abril de 2020Revocaciones. Apo.Sol.: GARCIA GONZALEZ NURIA. Apoderado: SOLER VOCK CARLOS. Nombramientos. Apoderado: ORGAZSANCHEZ SARA;CARRASCO GARCIA PAULA. Datos registrales. T 37570 , F 97, S 8, H M 669668, I/A 13 (27.03.20).
25 de Noviembre de 2019Revocaciones. Apo.Man.Soli: COK HUBRECHT JAN;ZUIDHOF MARC ALEXANDER;SYMONDSON REBECA ANN;BRADLEYPIERS;SOLER VOCK CARLOS. Datos registrales. T 37570 , F 97, S 8, H M 669668, I/A 12 (18.11.19).