Actos BORME de Whisbi Technologies Sl
23 de Mayo de 2023Otros conceptos: JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 7 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO45/2023, AUTO FIRME DE FECHA 27/03/2023, ARCHIVO DE LA PIEZA DE CALIFICACION DEL CONCURSO DE LA SOCIEDAD.Datos registrales. T 48220 , F 208, S 8, H B 398990, I/A 47 (17.05.23).
08 de Mayo de 2023Otros conceptos: JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 7 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO45/2023, AUTOS FIRMES DE FECHA 01/03/2023: POR EL QUE SE ACUERDA FIJAR LAS REGLAS ESPECIALES DELIQUIDACION; Y 27/03/2023: FINALIZACION DE LA FASE COMUN. Datos registrales. T 48220 , F 206, S 8, H B 398990, I/A 46(28.04.23).
27 de Marzo de 2023Revocaciones. ADM.SOLIDAR.: CANTERO ESCOLA JOSE LUIS;NILS MAGNUS FREDRIK JOHNSSON. Otros conceptos:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 7 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 45/2023, AUTOFIRME DE FECHA 15/02/2023, APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION. Disoluci贸n. Judicial. Datos registrales. T 48220 , F206, S 8, H B 398990, I/A 45 (20.03.23).
17 de Febrero de 2023Nombramientos. ADM.CONCURS.: ALFA FORENSIS SLP. REP.ADM.CONC: CRUZ DE PABLO JORGE. Otros conceptos:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 7 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO ABREVIADO DE CONCURSO VOLUNTARIO45/2023, AUTO FIRME DE FECHA 12/01/2023, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD. Datosregistrales. T 48220 , F 205, S 8, H B 398990, I/A 44 (13.02.23).
14 de Febrero de 2023Nombramientos. AUDIT.CUENT.: BDO AUDITORES SLP. Datos registrales. T 48220 , F 205, S 8, H B 398990, I/A 43 ( 6.02.23).
17 de Noviembre de 2022Revocaciones. APODERADO: BISBE TOSAT ALEXANDRE. APODERAD.SOL: BISBE TOSAT ALEXANDRE. ADM.SOLIDAR.:BISBE TOSAT ALEXANDRE. APODERAD.SOL: GIRALT DOMINGO ALEJANDRO. Nombramientos. ADM.SOLIDAR.: NILSMAGNUS FREDRIK JOHNSSON. Datos registrales. T 48220 , F 205, S 8, H B 398990, I/A 42 (10.11.22).
08 de Julio de 2022Cambio de domicilio social. AV DIAGONAL Num.444 P.5 (BARCELONA). Datos registrales. T 48220 , F 205, S 8, H B 398990, I/A41 ( 1.07.22).
01 de Marzo de 2022Reelecciones. Auditor: BDO AUDITORES SLP. Datos registrales. T 36826 , F 216, S 8, H M 479964, I/A 20 (22.02.22).
Modificaciones estatutarias. Modificado el art铆culo 5潞 de los estatutos sociales.. Datos registrales. T 36826 , F 216, S 8, H M479964, I/A 21 (22.02.22).
22 de Febrero de 2022Ampliaci贸n de capital. Capital: 852,32 Euros. Resultante Suscrito: 5.757,87 Euros. Datos registrales. T 36826 , F 214, S 8, H M479964, I/A 19 (15.02.22).
07 de Diciembre de 2021Modificaciones estatutarias. Modficaci贸n del art铆culo 5 de los Estatutos sociales . Reclasificaci贸n de las participaciones sociales dedeterminados socios. . Datos registrales. T 36826 , F 213, S 8, H M 479964, I/A 18 (29.11.21).
14 de Septiembre de 2021Revocaciones. Apoderado: LOPEZ TRUJILLO MARIA ISABEL. Nombramientos. Apoderado: GIRALT DOMINGO ALEJANDRO.Datos registrales. T 36826 , F 212, S 8, H M 479964, I/A 17 ( 7.09.21).
01 de Julio de 2021Cambio de domicilio social. PASEO DE LA CASTELLANA 43 - PLANTA 3 (MADRID). Datos registrales. T 36826 , F 212, S 8, H M479964, I/A 16 (24.06.21).
19 de Abril de 2021Reelecciones. Auditor: BDO AUDITORES SLP. Datos registrales. T 36826 , F 212, S 8, H M 479964, I/A 15 (12.04.21).
05 de Abril de 2021Revocaciones. Apoderado: ACTIVE VENTURE PARTNERS SGECR SA. Datos registrales. T 36826 , F 211, S 8, H M 479964, I/A14 (25.03.21).
11 de Febrero de 2021Modificaciones estatutarias. Modificado el art铆culo 17 de los Estatutos Sociales. Datos registrales. T 36826 , F 211, S 8, H M479964, I/A 13 ( 4.02.21).
14 de Septiembre de 2020Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: DERLIX SOLUTIONS SL. Datos registrales. T 36826 , F 209, S 8, H M 479964, I/A12 ( 7.09.20).
01 de Julio de 2020Reelecciones. Auditor: BDO AUDITORES SLP. Aud.C.Con.: BDO AUDITORES SLP. Datos registrales. T 36826 , F 209, S 8, H M479964, I/A 11 (24.06.20).
22 de Junio de 2020Revocaciones. Apoderado: TORRAS VILLACAMPA DULCIS. Nombramientos. Apoderado: LOPEZ TRUJILLO MARIA ISABEL.Datos registrales. T 36826 , F 208, S 8, H M 479964, I/A 10 (15.06.20).
07 de Noviembre de 2019Ceses/Dimisiones. Consejero: ACTIVE VENTURE PARTNERS SGECR SA;BISBE TOSAT ALEXANDRE. Presidente: BISBE TOSATALEXANDRE. Con.Delegado: BISBE TOSAT ALEXANDRE. Consejero: CANTERO ESCOLA JOSE LUIS;URS CETE;TORRASVILLACAMPA DULCIS. SecreNoConsj: PUYOL MARTINEZ-FERRANDO BLANCA. Representan: MACLAREN BLAIR.Nombramientos. Adm. Solid.: BISBE TOSAT ALEXANDRE;CANTERO ESCOLA JOSE LUIS. Ampliaci贸n de capital. Capital:829,19 Euros. Resultante Suscrito: 4.905,55 Euros. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo deadministraci贸n a Administradores solidarios. Datos registrales. T 36826 , F 201, S 8, H M 479964, I/A 9 (30.10.19).
04 de Septiembre de 2019Modificaciones estatutarias. Modificado el art铆culo 17 de los Estatutos Sociales. Datos registrales. T 36826 , F 201, S 8, H M479964, I/A 8 (28.08.19).
27 de Febrero de 2019Nombramientos. Aud.C.Con.: BDO AUDITORES SLP. Reelecciones. Auditor: BDO AUDITORES SLP. Datos registrales. T 36826, F 200, S 8, H M 479964, I/A 7 (20.02.19).
17 de Julio de 2018Nombramientos. Apoderado: GARCIA GARCIA RAUL. Datos registrales. T 36826 , F 200, S 8, H M 479964, I/A 6 (10.07.18).
11 de Abril de 2018Reelecciones. Auditor: BDO AUDITORES SLP. Datos registrales. T 36826 , F 200, S 8, H M 479964, I/A 5 ( 3.04.18).
05 de Febrero de 2018Modificaciones estatutarias. MODIFICACION DEL ARTICULO 17 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, REMUNERACION DE LOSCONSEJEROS.. Datos registrales. T 36826 , F 199, S 8, H M 479964, I/A 4 (26.01.18).
25 de Enero de 2018Cambio de domicilio social. AVDA DE MANOTERAS 26 5陋 (MADRID). Datos registrales. T 36826 , F 199, S 8, H M 479964, I/A 3(18.01.18).
09 de Marzo de 2017Nombramientos. APODERAD.SOL: BISBE TOSAT ALEXANDRE;CANTERO ESCOLA JOSE LUIS. Datos registrales. T 43399 , F7, S 8, H B 398990, I/A 21 ( 1.03.17).
17 de Febrero de 2017Nombramientos. AUDIT.CUENT.: BDO AUDITORES SLP. Datos registrales. T 43399 , F 6, S 8, H B 398990, I/A 20 ( 9.02.17).
02 de Febrero de 2016Nombramientos. AUDIT.CUENT.: BDO AUDITORES SL. Datos registrales. T 43399 , F 6, S 8, H B 398990, I/A 19 (25.01.16).
14 de Diciembre de 2015Revocaciones. CONSEJERO: VICENTE BLANCO MARCOS. Nombramientos. CONSEJERO: CETE URS. Datos registrales. T43399 , F 6, S 8, H B 398990, I/A 18 ( 4.12.15).
19 de Febrero de 2015Nombramientos. AUDIT.CUENT.: BDO AUDITORES SL. Datos registrales. T 43399 , F 5, S 8, H B 398990, I/A 17 (12.02.15).
16 de Diciembre de 2014Revocaciones. CONSEJERO: JAN BORGSTAEDT. Nombramientos. CONSEJERO: VICENTE BLANCO MARCOS. Datosregistrales. T 43399 , F 5, S 8, H B 398990, I/A 16 ( 4.12.14).
21 de Abril de 2014Nombramientos. CONSEJERO: JAN BORGSTAEDT;TORRAS VILLACAMPA DULCIS. Ampliaci贸n de capital. Capital: 729,13Euros. Resultante Suscrito: 4.069,13 Euros. Datos registrales. T 43399 , F 3, S 8, H B 398990, I/A 14 ( 9.04.14).
Ampliaci贸n de capital. Capital: 7,23 Euros. Resultante Suscrito: 4.076,36 Euros. Datos registrales. T 43399 , F 4, S 8, H B 398990,I/A 15 ( 9.04.14).
05 de Diciembre de 2013Cambio de objeto social. AMPLIAR A:LA PRESTACION DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES ELECTRONICAS. Datosregistrales. T 43399 , F 3, S 8, H B 398990, I/A 13 (27.11.13).
22 de Mayo de 2013Cambio de domicilio social. CL CALABRIA Num.169 P.10 (BARCELONA). Datos registrales. T 43399 , F 3, S 8, H B 398990, I/A12 (13.05.13).
26 de Octubre de 2012Ampliaci贸n de capital. Capital: 133,60 Euros. Resultante Suscrito: 3.340,00 Euros. Datos registrales. T 43092 , F 170, S 8, H B398990, I/A 11 (16.10.12).
19 de Junio de 2012Nombramientos. APODERADO: TORRAS VILLACAMPA DULCIS. Datos registrales. T 43092 , F 168, S 8, H B 398990, I/A 10 (7.06.12).
07 de Junio de 2012Cambio de domicilio social. CL TARRAGONA 149-157 P.14 PTA.1 (BARCELONA). Datos registrales. T 43092 , F 168, S 8, H B398990, I/A 9 (24.05.12).
25 de Mayo de 2012Nombramientos. AUDIT.CUENT.: BDO AUDITORES SL. Datos registrales. T 43092 , F 168, S 8, H B 398990, I/A 8 (16.05.12).
30 de Abril de 2012Revocaciones. ADM.UNICO: CANTERO ESCOLA JOSE LUIS. Nombramientos. CONSEJERO: BISBE TOSAT ALEXANDRE.PRESIDENTE: BISBE TOSAT ALEXANDRE. CONS. DELEG.: BISBE TOSAT ALEXANDRE. CONSEJERO: CANTERO ESCOLAJOSE LUIS;ACTIVE VENTURE PARTNERS SGECR SA. REPR.143 RRM: BLAIR MACLAREN. SECR.NO CONS: PUYOL MARTINEZFERRANDO BLANCA. APODERADO: ACTIVE VENTURE PARTNERS SGECR SA. Ampliaci贸n de capital. Capital: 200,40 Euros.Resultante Suscrito: 3.206,40 Euros. Modificaciones estatutarias. MODIFICACION Y REFUNDICION DE LOS ESTATUTOSSOCIALES. Datos registrales. T 41842 , F 130, S 8, H B 398990, I/A 7 (19.04.12).
28 de Febrero de 2012Modificaciones estatutarias. ART.6:MODIFICACION DEL VALOR NOMINAL Y DEL NUMERO DE LAS PARTICIPACIONESSOCIALES. Datos registrales. T 41842 , F 130, S 8, H B 398990, I/A 6 (16.02.12).
23 de Diciembre de 2011Nombramientos. APODERADO: BISBE TOSAT ALEXANDRE. Datos registrales. T 41842 , F 128, S 8, H B 398990, I/A 5(12.12.11).
07 de Diciembre de 2011Revocaciones. ADM.UNICO: BISBE TOSAT ALEXANDRE. Nombramientos. ADM.UNICO: CANTERO ESCOLA JOSE LUIS.Cambio de objeto social. AMPLIAR A:LA INTERVENCION EN CUALQUIER TIPO DE OPERACIONES COMO AGENTECONFORME A LO DISPUESTO EN LA LEY 12/1992 DEL CONTRATO DE AGENCIA,O NORMA QUE LA SUSTITUYA.LACAPTACION Y GRABACION MEDIANTE EQUIPOS INFORMATICOS DE... Datos registrales. T 41842 , F 127, S 8, H B 398990, I/A
03 de Mayo de 2010Nombramientos. APODERADO: CANTERO ESCOLA JOSE LUIS. Datos registrales. T 41842 , F 123, S 8, H B 398990, I/A 3(20.04.10).