Buscador CIF Logo

Actos BORME Winche Redes Comerciales Sl

¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Winche Redes Comerciales Sl

Actos BORME Winche Redes Comerciales Sl - B62926266

Tenemos registrados 38 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Winche Redes Comerciales Sl con CIF B62926266

🔙 Perfil de Winche Redes Comerciales Sl
🛒 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Winche Redes Comerciales Sl

26 de Diciembre de 2023
Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Aud.C.Con.: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 36615 , F 90, S 8, H M656974, I/A 24 (18.12.23).

28 de Julio de 2023
Declaración de unipersonalidad. Socio único: SRWK SAS. Ceses/Dimisiones. Consejero: SCHERK SERRAT JAVIER.Con.Delegado: SCHERK SERRAT JAVIER. Presidente: SCHERK SERRAT JAVIER. Consejero: AURICA CAPITAL DESARROLLOS.G.E.I.C. S.A.;SOBRADIA XXI SL;SCHERK MASNOU RICARDO;MARAGALL DE GISPERT MANEL. SecreNoConsj: MONTESINOESPARTERO VELASCO IÑIGO. Representan: CONTI PENINA FERRAN;PEREZ CALDAYA PABLO. Nombramientos. Consejero:FINSEL MADRID 2018 SL;MAINDIAUX GUY;SRWK SAS. Presidente: FINSEL MADRID 2018 SL. Secretario: SRWK SAS.Representan: SCHERK SERRAT JAVIER;DURIER CHRISTOPHE LUC MARC. Datos registrales. T 36615 , F 87, S 8, H M 656974,I/A 21 (21.07.23).

Nombramientos. Apoderado: FINSEL MADRID 2018 SL. Datos registrales. T 36615 , F 88, S 8, H M 656974, I/A 22 (21.07.23).

Nombramientos. Apo.Sol.: DE TABOADA ELENA ANNEZ;CALVO SCHWARZWALDER ALEJANDRO. Datos registrales. T 36615 ,F 89, S 8, H M 656974, I/A 23 (21.07.23).

22 de Diciembre de 2022
Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Aud.C.Con.: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 36615 , F 87, S 8, H M656974, I/A 20 (15.12.22).

18 de Noviembre de 2022
Ceses/Dimisiones. Representan: VARGAS BEATO MARTIN. Nombramientos. Representan: PEREZ CALDAYA PABLO. Datosregistrales. T 36615 , F 87, S 8, H M 656974, I/A 19 (11.11.22).

09 de Mayo de 2022
Ceses/Dimisiones. Consejero: PIJOAN MARIN JAVIER. Datos registrales. T 36615 , F 86, S 8, H M 656974, I/A 17 (29.04.22).

Nombramientos. Consejero: MARAGALL DE GISPERT MANEL. Datos registrales. T 36615 , F 87, S 8, H M 656974, I/A 18(29.04.22).

01 de Febrero de 2022
Nombramientos. Apoderado: ROCHER GONZALEZ MARC. Datos registrales. T 36615 , F 84, S 8, H M 656974, I/A 15 (25.01.22).

Ceses/Dimisiones. Consejero: ROCHER GONZALEZ MARC. Nombramientos. Consejero: SCHERK MASNOU RICARDO.

01 de Septiembre de 2021
Ceses/Dimisiones. Consejero: HOBALEAR SA. Representan: PLAZA FERRIZ IVAN;RODRIGUEZ SABATER RAUL.Nombramientos. Consejero: SOBRADIA XXI SL. Representan: VARGAS BEATO MARTIN;CONTI PENINA FERRAN. Datosregistrales. T 36615 , F 83, S 8, H M 656974, I/A 13 (25.08.21).

Ceses/Dimisiones. Consejero: PETIT SALOMO JORDI. Nombramientos. Consejero: PIJOAN MARIN JAVIER. Datos registrales.T 36615 , F 83, S 8, H M 656974, I/A 14 (25.08.21).

16 de Junio de 2021
Ceses/Dimisiones. VsecrNoConsj: CHENG ZHANG WEN WEN. SecreNoConsj: GIL ROIG RAMON. Nombramientos.SecreNoConsj: MONTESINO ESPARTERO VELASCO IÑIGO. Datos registrales. T 36615 , F 82, S 8, H M 656974, I/A 12 ( 9.06.21).

18 de Noviembre de 2020
Revocaciones. Apoderado: NIETO SASTRE EVA;NIETO SASTRE EVA. Nombramientos. Apoderado: SANCHEZ MORONCARLOS;VICENTE MARTIN DAVID. Datos registrales. T 36615 , F 81, S 8, H M 656974, I/A 11 (11.11.20).

19 de Febrero de 2020
Ceses/Dimisiones. Consejero: TORRAS CONSOLACION LUIS. Nombramientos. Consejero: ROCHER GONZALEZ MARC. Datosregistrales. T 36615 , F 81, S 8, H M 656974, I/A 10 (12.02.20).

29 de Julio de 2019
Modificaciones estatutarias. MODIFICACION DEL ARTICULO 20. RETRIBUCION.- . Datos registrales. T 36615 , F 81, S 8, H M656974, I/A 9 (19.07.19).

07 de Junio de 2019
Nombramientos. Apoderado: NIETO SASTRE EVA;VICENTE MARTIN DAVID. Datos registrales. T 36615 , F 80, S 8, H M 656974,I/A 8 (31.05.19).

22 de Mayo de 2019
Revocaciones. Auditor: EQUIFOND AUDITORES SL. Nombramientos. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Aud.C.Con.: KPMGAUDITORES SL. Datos registrales. T 36615 , F 79, S 8, H M 656974, I/A 7 (14.05.19).

29 de Marzo de 2019
Nombramientos. Apoderado: MASNOU MORERA MARIA ANGELES. Datos registrales. T 36615 , F 79, S 8, H M 656974, I/A 6(22.03.19).

05 de Diciembre de 2018
Ceses/Dimisiones. Secretario: TORRAS CONSOLACION LUIS. Nombramientos. VsecrNoConsj: CHENG ZHANG WEN WEN.Representan: PLAZA FERRIZ IVAN;RODRIGUEZ SABATER RAUL. Consejero: AURICA CAPITAL DESARROLLO S.G.E.I.C.

15 de Noviembre de 2018
Modificaciones estatutarias. Se modifican los artículos 2 y 5 de los estatutos sociales, y se aprueba el texto refundido de losestatutos sociales. . Otros conceptos: Se crean 18.000 participaciones de la clase A, de 1 euro de valor nominal, números 12.001 al30.000, inclusive. Se crean 12.000 participaciones clase B, de 1 euro de valor nominal, números 1 al 12.000, inclusive. Cambio deobjeto social. -La Sociedad tiene como objeto social la realización de campañas publicitarias y de marketing, merchandising ypromociones de venta de todo tipo de productos, incluyendo la externalización de la fuerza de ventas y gestión de puntos de venta.Datos registrales. T 36615 , F 72, S 8, H M 656974, I/A 4 ( 7.11.18).

02 de Enero de 2018
Ceses/Dimisiones. Consejero: COSTAFREDA GIMENO ALBERTO;PIERREMONT MYLENE MARIE. Nombramientos. Consejero:PETIT SALOMO JORDI. Datos registrales. T 36615 , F 72, S 8, H M 656974, I/A 3 (21.12.17).

22 de Noviembre de 2017
Cambio de domicilio social. C/ PRINCIPE DE VERGARA 109 2 (MADRID). Datos registrales. T 36615 , F 72, S 8, H M 656974, I/A2 (15.11.17).

16 de Junio de 2017
Cambio de domicilio social. AV DIAGONAL NUM.453 BIS P.3 (BARCELONA). Datos registrales. T 44296 , F 53, S 8, H B 249457,I/A 22 ( 8.06.17).

16 de Enero de 2017
Revocaciones. APODERAD.SOL: PILON VILA EDUARDO. APOD.MANCOMU: SALMURRI LINARES ALVARO. Datos registrales.T 44296 , F 52, S 8, H B 249457, I/A 21 ( 5.01.17).

30 de Diciembre de 2016
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: EQUIFOND AUDITORES SL. Datos registrales. T 44296 , F 52, S 8, H B 249457, I/A 20(21.12.16).

02 de Marzo de 2016
Revocaciones. CONSEJERO: SALMURRI LINARES ALVARO. SECRETARIO: SALMURRI LINARES ALVARO. Datos registrales. T44296 , F 52, S 8, H B 249457, I/A 17 (19.02.16).

Revocaciones. CONSEJERO: ROIG BATISTA VICTOR. Nombramientos. SECRETARIO: TORRAS CONSOLACION LUIS. Datosregistrales. T 44296 , F 52, S 8, H B 249457, I/A 18 (19.02.16).

Nombramientos. AUDIT.CUENT.: FISCAUDI AUDITORES ASOCIADOS SA. Datos registrales. T 44296 , F 52, S 8, H B 249457,I/A 19 (19.02.16).

23 de Enero de 2015
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: FISCAUDI AUDITORES ASOCIADOS SA. Datos registrales. T 44296 , F 51, S 8, H B 249457,I/A 16 (16.01.15).

19 de Diciembre de 2014
Revocaciones. CONSEJERO: GANDARA MARTINEZ VELASCO JAVIER. Datos registrales. T 44296 , F 51, S 8, H B 249457, I/A15 (11.12.14).

09 de Mayo de 2014
Revocaciones. APODERADO: PILON VILA EDUARDO;MASNOU MORERA MARIA ANGELS;VICENTE MARTIN DAVID;NIETOSASTRE EVA. Nombramientos. APOD.SOL/MAN: NIETO SASTRE EVA;VICENTE MARTIN DAVID. APODERAD.SOL: PILON VILA

13 de Enero de 2014
Nombramientos. CONSEJERO: MYLENE MARIE PIERREMONT. Datos registrales. T 34769 , F 87, S 8, H B 249457, I/A 13 (2.01.14).

06 de Agosto de 2013
Nombramientos. CONSEJERO: GANDARA MARTINEZ VELASCO JAVIER. Datos registrales. T 34769 , F 87, S 8, H B 249457, I/A12 (26.07.13).

03 de Julio de 2013
Revocaciones. CONSEJERO: LOPEZ COSTAS FELIPE. Datos registrales. T 34769 , F 87, S 8, H B 249457, I/A 11 (26.06.13).

17 de Febrero de 2012
Revocaciones. CONSEJERO: MASNOU MORERA MARIA ANGELES. SECRETARIO: MASNOU MORERA MARIA ANGELES.CONSEJERO: NIETO SASTRE EVA. Nombramientos. CONSEJERO: SCHERK SERRAT JAVIER. PRESIDENTE: SCHERKSERRAT JAVIER. CONS. DELEG.: SCHERK SERRAT JAVIER. CONSEJERO: TORRAS CONSOLACION LUIS;ROIG BATISTAVICTOR;COSTAFREDA GIMENO ALBERTO;LOPEZ COSTAS FELIPE;SALMURRI LINARES ALVARO. SECRETARIO: SALMURRILINARES ALVARO. Datos registrales. T 34769 , F 87, S 8, H B 249457, I/A 10 ( 7.02.12).

26 de Enero de 2012
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: FISCAUDI AUDITORES ASOCIADOS SA. Datos registrales. T 34769 , F 86, S 8, H B 249457,I/A 9 (13.01.12).

15 de Septiembre de 2011
Revocaciones. CONSEJERO: MIRALTA GONCALVES DE FARIA FERNANDO. Nombramientos. CONSEJERO: NIETO SASTREEVA. Datos registrales. T 34769 , F 86, S 8, H B 249457, I/A 8 ( 2.09.11).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información