Buscador CIF Logo

Actos BORME Wonderfood Brands Corporation Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Wonderfood Brands Corporation Sl

Actos BORME Wonderfood Brands Corporation Sl - B86114493

Tenemos registrados 15 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Wonderfood Brands Corporation Sl con CIF B86114493

馃敊 Perfil de Wonderfood Brands Corporation Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Wonderfood Brands Corporation Sl

13 de Agosto de 2020
Revocaciones. Apoderado: MU脩OZ VILCHEZ JESUS MANUEL;MU脩OZ VILCHEZ JESUS MANUEL;MU脩OZ VILCHEZ JESUSMANUEL Nombramientos. Apoderado: SERRANO BARRERO MARIA PAZ;DE EUSEBIO GARCIA SERGIO. Datos registrales. T

25 de Marzo de 2020
Nombramientos. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 37589 , F 225, S 8, H M 578517, I/A 10 (18.03.20).

17 de Enero de 2020
Disoluci贸n. Fusion. Extinci贸n. Datos registrales. T 28407 , F 86, S 8, H M 511553, I/A 13 (10.01.20).

13 de Marzo de 2019
Nombramientos. Apoderado: JIMENEZ ALBA RAIMUNDO;DEL BARRIO ABADIE GONZALO;SANCHEZ OTERO JAVIER;MU脩OZVILCHEZ JESUS MANUEL. Datos registrales. T 28407 , F 86, S 8, H M 511553, I/A 12 ( 5.03.19).

31 de Diciembre de 2018
Nombramientos. Apoderado: RIGAU PAGES JAVIER;JIMENEZ ALBA RAIMUNDO;DEL BARRIO ABADIE GONZALO;SANCHEZOTERO JAVIER;MU脩OZ VILCHEZ JESUS MANUEL;PINYA SALOMO ORIOL;MOLINS VILATA LLUIS;RIVAS ROMERO-VALDESPINO SERGIO. Datos registrales. T 28407 , F 82, S 8, H M 511553, I/A 10 (21.12.18).

Nombramientos. Apoderado: CASALS OVALLE LUIS;PIQUERO AMELA ELENA;RODRIGUEZ TORRES IRIA;CORRAL MORENOJUAN JOSE. Datos registrales. T 28407 , F 85, S 8, H M 511553, I/A 11 (21.12.18).

19 de Septiembre de 2018
Nombramientos. Apoderado: PEREIRA DAVILA VICTOR-MANUEL. Datos registrales. T 28407 , F 82, S 8, H M 511553, I/A 9(11.09.18).

21 de Junio de 2018
Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: EATING GROUP VENTURES SA. Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: EMILIO LOPEZGARCIA. Nombramientos. Adm. Unico: RIVAS ROMERO-VALDESPINO SERGIO. Cambio de domicilio social. C/ ARRASTARIA21 1陋 (MADRID). Datos registrales. T 28407 , F 74, S 8, H M 511553, I/A 7 (14.06.18).

Nombramientos. Apoderado: RIVAS ROMERO-VALDESPINO SERGIO;FERNANDEZ NARVAEZ DAVID;DEL BARRIO ABADIEGONZALO;SANCHEZ OTERO JAVIER;MU脩OZ VILCHEZ JESUS MANUEL;ORTIGOSA ROMERO MARIA ARANZAZU;JIMENEZALBA RAIMUNDO;MOLINS VILATA LLUIS;RIGAU PAGES JAVIER;PINYA SALOMO ORIOL. Datos registrales. T 28407 , F 76, S 8,H M 511553, I/A 8 (14.06.18).

30 de Mayo de 2017
Ampliacion del objeto social. a) Explotaci贸n de toda clase de negocios de hosteler铆a y alimentaci贸n, tales como bares, bodegas,pubs, discotecas, salas de fiesta, cafeter铆as, caf茅, espect谩culo, restaurantes, salones para comidas, hoteles, hostales, servicios decomida preparada para llevar en el propio establecimiento... Datos registrales. T 28407 , F 74, S 8, H M 511553, I/A 6 (22.05.17).

21 de Mayo de 2013
Cambio de domicilio social. C/ CHICUELO 21 (MADRID). Datos registrales. T 28407 , F 73, S 8, H M 511553, I/A 5 (10.05.13).

05 de Julio de 2012
Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: RIVAS FOLGUEIRAS ROBERTO;LOPEZ GARCIA EMILIO. Nombramientos. Adm. Unico:EMILIO LOPEZ GARCIA. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n: Administradores mancomunados aAdministrador 煤nico. Datos registrales. T 28407 , F 73, S 8, H M 511553, I/A 3 (25.06.12).

Cambio de domicilio social. C/ ALGABE脩O 1 (MADRID). Datos registrales. T 28407 , F 73, S 8, H M 511553, I/A 4 (25.06.12).

14 de Septiembre de 2011
Ceses/Dimisiones. Consejero: PELAYO SANCHEZ FRANCISCO JAVIER;LOPEZ GARCIA EMILIO;RIVAS FOLGUEIRASROBERTO. Presidente: PELAYO SANCHEZ FRANCISCO JAVIER. Vicepresid.: LOPEZ GARCIA EMILIO. Secretario: RIVASFOLGUEIRAS ROBERTO. Nombramientos. Adm. Mancom.: RIVAS FOLGUEIRAS ROBERTO;LOPEZ GARCIA EMILIO.Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administradores mancomunados.Datos registrales. T 28407 , F 73, S 8, H M 511553, I/A 2 ( 1.09.11).

02 de Febrero de 2011
Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 27.12.10. Objeto social: LA EXPLOTACION DE TODA CLASE DE NEGOCIOS DEHOSTELERIA Y ALIMENTACION...C. Domicilio: C/ PEDRO TEIXEIRA 8 (MADRID). Capital: 30.000,00 Euros. Nombramientos.Consejero: PELAYO SANCHEZ FRANCISCO JAVIER;LOPEZ GARCIA EMILIO;RIVAS FOLGUEIRAS ROBERTO. Presidente:PELAYO SANCHEZ FRANCISCO JAVIER. Vicepresid.: LOPEZ GARCIA EMILIO. Secretario: RIVAS FOLGUEIRAS ROBERTO.Datos registrales. T 28407 , F 70, S 8, H M 511553, I/A 1 (18.01.11).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n