Buscador CIF Logo

Actos BORME World Duty Free Group Sociedad Anonima

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera World Duty Free Group Sociedad Anonima

Actos BORME World Duty Free Group Sociedad Anonima - A84205863

Tenemos registrados 43 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para World Duty Free Group Sociedad Anonima con CIF A84205863

馃敊 Perfil de World Duty Free Group Sociedad Anonima
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de World Duty Free Group Sociedad Anonima

16 de Octubre de 2023
Ceses/Dimisiones. Secretario: ADRIANI MIRAPURI KARINA. Consejero: ANDRADES YUNTA EUGENIO. Presidente: ANDRADESYUNTA EUGENIO. Cons.Del.Man: ANDRADES YUNTA EUGENIO. Nombramientos. SecreNoConsj: OCAMPO NICOLASEDWARD. Consejero: ZARZA GARCIA ISABEL. Presidente: ZARZA GARCIA ISABEL. Datos registrales. T 39269 , F 79, S 8, H M365571, I/A 104 ( 6.10.23).

28 de Noviembre de 2022
Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: MIRALDA DE CIARAN JOSE. Nombramientos. Secretario: ADRIANI MIRAPURI KARINA.Datos registrales. T 39269 , F 79, S 8, H M 365571, I/A 103 (21.11.22).

22 de Junio de 2022
Revocaciones. Apoderado: VALLEJO ANDREA CRISTINA;GOMEZ PINEDA PABLO;DE AYALA PRADO MIGUEL PABLO;MIRALDADE CIARAN JOSE;WIC MORAL ROSARIO;CALDERON DIEZ JUAN NORBERTO. Apo.Manc.: ANDRADES YUNTA

Ceses/Dimisiones. Consejero: DIAZ GONZALEZ JULIAN. Presidente: DIAZ GONZALEZ JULIAN. Cons.Del.Man: DIAZ GONZALEZJULIAN. Nombramientos. Consejero: ANDRADES YUNTA EUGENIO. Presidente: ANDRADES YUNTA EUGENIO. Cons.Del.Man:ANDRADES YUNTA EUGENIO. Reelecciones. Consejero: MARIN MAS SARDA LUIS. Cons.Del.Man: MARIN MAS SARDA LUIS.Datos registrales. T 39269 , F 78, S 8, H M 365571, I/A 102 (15.06.22).

22 de Noviembre de 2021
Nombramientos. Apo.Manc.: ANDRADES YUNTA EUGENIO MIGUEL;MONTESDEOCA CASADO ANGELES. Datos registrales. T39269 , F 76, S 8, H M 365571, I/A 100 (15.11.21).

10 de Noviembre de 2021
Nombramientos. Apoderado: ROJAS VAZQUEZ NOELIA ISABEL;MARTINEZ LOPEZ DOLORES. Datos registrales. T 39269 , F75, S 8, H M 365571, I/A 99 ( 2.11.21).

27 de Julio de 2021
Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 39269 , F 75, S 8, H M 365571, I/A 98 (20.07.21).

16 de Julio de 2021
Revocaciones. Consejero: ANDRADES YUNTA EUGENIO. Cons.Del.Man: ANDRADES YUNTA EUGENIO. Apoderado: ANDRADESYUNTA EUGENIO;MONTESDEOCA CASADO ANGELES. Nombramientos. Consejero: RODRIGUEZ-CARO MERINO JOSEMANUEL. Apo.Manc.: ANDRADES YUNTA EUGENIO;MONTESDEOCA CASADO ANGELES. Datos registrales. T 39269 , F 74, S 8,H M 365571, I/A 97 ( 9.07.21).

24 de Febrero de 2021
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 39269 , F 74, S 8, H M 365571, I/A 96 (17.02.21).

10 de Febrero de 2021
Nombramientos. Apo.Manc.: TOM AUSSEMS;CARINA JARMUCHOWICZ;MARK THOMASSEN;PETER VAN DER SCHEE. Datosregistrales. T 39269 , F 73, S 8, H M 365571, I/A 94 ( 3.02.21).

Nombramientos. Apo.Manc.: RODRIGUEZ-CARO MERINO JOSE MANUEL. Datos registrales. T 39269 , F 73, S 8, H M 365571,I/A 95 ( 3.02.21).

30 de Diciembre de 2020
Ceses/Dimisiones. Consejero: CASTRO BENITEZ PEDRO. Cons.Del.Man: CASTRO BENITEZ PEDRO. Datos registrales. T 39269, F 73, S 8, H M 365571, I/A 93 (22.12.20).

28 de Septiembre de 2020
Nombramientos. Apoderado: ANDRADES YUNTA EUGENIO;MONTESDEOCA CASADO ANGELES;VALLEJO ANDREACRISTINA;GOMEZ PINEDA PABLO;BAS LOSTAO PABLO;DE AYALA PRADO MIGUEL PABLO;MIRALDA DE CIARAN JOSE;WICMORAL ROSARIO;CALDERON DIEZ JUAN NORBERTO. Datos registrales. T 39269 , F 71, S 8, H M 365571, I/A 92 (21.09.20).

30 de Septiembre de 2019
Revocaciones. Apoderado: DIAZ MANCHES PELAYO;CARRION MORAN MARIA. Nombramientos. Apoderado: GARCIA SUAREZCOVADONGA;GOMEZ JIMENEZ PILAR. Datos registrales. T 32945 , F 142, S 8, H M 365571, I/A 91 (23.09.19).

25 de Julio de 2019
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 32945 , F 142, S 8, H M 365571, I/A 90 (18.07.19).

15 de Julio de 2019
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 320,00 Euros. Resultante Suscrito: 19.831.379,00 Euros. Datos registrales. T 32945 , F142, S 8, H M 365571, I/A 89 ( 8.07.19).

11 de Julio de 2019
Nombramientos. Apoderado: GOMEZ PINEDA PABLO;MURO FERNANDEZ TOMAS. Datos registrales. T 32945 , F 142, S 8, H M365571, I/A 88 ( 4.07.19).

02 de Julio de 2019
Ceses/Dimisiones. Consejero: BAS LOSTAO PABLO. Cons.Del.Man: BAS LOSTAO PABLO. Revocaciones. Apo.Man.Soli:CASTRO BENITEZ PEDRO;BAS LOSTAO PABLO;MONTESDEOCA CASADO ANGELES;VALLEJO ANDREA CRISTINA;DIAZ-MEREDIZ HEVIA ALFONSO;GOMEZ PINEDA PABLO. Nombramientos. Consejero: ANDRADES YUNTA EUGENIO. Cons.Del.Man:ANDRADES YUNTA EUGENIO. Apo.Man.Soli: CASTRO BENITEZ PEDRO;MONTESDEOCA CASADO ANGELES;VALLEJOANDREA CRISTINA;GOMEZ PINEDA PABLO;CA脩AS HERNANDEZ JAVIER;DE AYALA PRADO MIGUEL PABLO;MURO

22 de Marzo de 2019
Nombramientos. Apo.Man.Soli: CASTRO BENITEZ PEDRO;BAS LOSTAO PABLO;MONTESDEOCA CASADO ANGELES;VALLEJOANDREA CRISTINA;DIAZ-MEREDIZ HEVIA ALFONSO;GOMEZ PINEDA PABLO. Datos registrales. T 32945 , F 139, S 8, H M365571, I/A 86 (15.03.19).

28 de Enero de 2019
Revocaciones. Apo.Man.Soli: MARTINEZ SUAREZ MIGUEL ANGEL;LUCENA RODRIGUEZ FRANCISCO. Nombramientos.Apo.Sol.: LUCENA RODRIGUEZ FRANCISCO. Datos registrales. T 32945 , F 139, S 8, H M 365571, I/A 85 (21.01.19).

24 de Enero de 2019
Nombramientos. Apoderado: MONTESDEOCA CASADO ANGELES;GOMEZ PINEDA PABLO. Datos registrales. T 32945 , F 138,S 8, H M 365571, I/A 84 (17.01.19).

25 de Julio de 2018
Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: WORLD DUTY FREE SRL. Datos registrales. T 32945 , F 137, S 8, H M 365571,I/A 83 (18.07.18).

12 de Julio de 2018
Nombramientos. Apo.Sol.: BRET ESCALES JORDI;MARTINEZ FRANCO JUANA. Datos registrales. T 32945 , F 137, S 8, H M365571, I/A 82 ( 4.07.18).

09 de Marzo de 2018
Nombramientos. Apo.Man.Soli: CASTRO BENITEZ PEDRO;BAS LOSTAO PABLO;MARTINEZ SUAREZ MIGUEL ANGEL;LUCENARODRIGUEZ FRANCISCO;VALLEJO ANDREA CRISTINA. Apo.Sol.: DIAZ-MEREDIZ HEVIA ALFONSO;GOMEZ PINEDA PABLO.Datos registrales. T 32945 , F 136, S 8, H M 365571, I/A 81 ( 1.03.18).

26 de Enero de 2018
Revocaciones. Apoderado: BAS LOSTAO PABLO;ANDRADES YUNTA EUGENIO;NADAL RUBIO FERNANDO;DIAZ-MEREDIZHEVIA ALFONSO;ZARZA GARCIA ISABEL;PEREZ PE脩A DEL LLANO FERNANDO;CASTRO BENITEZ PEDRO;GRANDE PRIETOCARLOS;MIRALDA DE CIARAN JOSE;RODRIGUEZ-CARO MERINO JOSE MANUEL;BRET ESCALES JORDI;AGUILAR BLANCOJAIME LUIS;LUNA VIDAL JOSE;SIMON GUERRA ANTONIO;ANDRADES YUNTA EUGENIO;BAS LOSTAO PABLO;CASTROBENITEZ PEDRO;FARFAN TRELLES EDGAR;SANTARELLI PARED NANCY;SORIA CHUQUILIN EVELYN-PATRICIA;PEREZALGARATE FELIPE-GUSTAVO;NADAL RUBIO FERNANDO;RODRIGUEZ-CARO MERINO JOSE MANUEL;MIRALDA DE CIARANJOSE. Apo.Man.Soli: CREIGHTON FREDERICK ROBERT;PETCHEY MARTIN. Apo.Manc.: JIMENEZ-BLANCO CARRILLO DEALBORNOZ DAVID MARIA;ANDRADES YUNTA EUGENIO;BAS LOSTAO PABLO;RODRIGUEZ-CARO MERINO JOSE MANUEL.Datos registrales. T 32945 , F 135, S 8, H M 365571, I/A 80 (18.01.18).

14 de Junio de 2017
Revocaciones. Apo.Sol.: LUNA VIDAL JOSE. Nombramientos. Apoderado: LAFULLA MATEO FELIX. Datos registrales. T 32945, F 135, S 8, H M 365571, I/A 79 ( 7.06.17).

09 de Mayo de 2017
Nombramientos. Apoderado: RODRIGUEZ DUE脩AS JOSE. Datos registrales. T 32945 , F 133, S 8, H M 365571, I/A 77 (25.04.17).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: CASTRO BENITEZ PEDRO;BAS LOSTAO PABLO;MARTINEZ SUAREZ MIGUEL ANGEL;LUCENARODRIGUEZ FRANCISCO;VALLEJO ANDREA CRISTINA;DIAZ-MEREDIZ HEVIA ALFONSO;GOMEZ PINEDA PABLO. Datosregistrales. T 32945 , F 134, S 8, H M 365571, I/A 78 (25.04.17).

23 de Enero de 2017
Nombramientos. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 32945 , F 133, S 8, H M 365571, I/A 76 (16.01.17).

16 de Noviembre de 2016
Revocaciones. Apoderado: OLIVERA MASSO PABLO;JIMENEZ-BLANCO CARRILLO DE ALBORNOZ DAVID MARIA;JIMENEZ-BLANCO CARRILLO DE ALBORNOZ DAVID MARIA;OLIVERA MASSO PABLO. Datos registrales. T 32945 , F 133, S 8, H M365571, I/A 75 ( 8.11.16).

20 de Octubre de 2016
Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: OLIVERA MASSO PABLO. Nombramientos. SecreNoConsj: MIRALDA DE CIARAN JOSE.Datos registrales. T 32945 , F 133, S 8, H M 365571, I/A 74 (11.10.16).

03 de Octubre de 2016
Nombramientos. Apo.Sol.: CAPO CUCHERAT JAIME. Datos registrales. T 32945 , F 132, S 8, H M 365571, I/A 73 (23.09.16).

07 de Septiembre de 2016
Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: DUFRY HISPANOSUIZA SL. Datos registrales. T 32945 , F 130, S 8, H M 365571,I/A 72 (26.08.16).

05 de Mayo de 2016
Nombramientos. Apoderado: CASTRO BENITEZ PEDRO;MARTINEZ SUAREZ MIGUEL ANGEL;LUCENA RODRIGUEZFRANCISCO;BAS LOSTAO PABLO;RODRIGUEZ-CARO MERINO JOSE MANUEL;VALLEJO ANDREA CRISTINA;DIAZ-MEREDIZHEVIA ALFONSO;GOMEZ PINEDA PABLO. Datos registrales. T 32945 , F 129, S 8, H M 365571, I/A 71 (26.04.16).

19 de Abril de 2016
Otros conceptos: Ha sido publicado en el BORME la insercci贸n del proyecto de fusi贸n referente a las sociedades "World Duty FreeGroup SA" como Absorbente y de la sociedad ""Dufry Hispanosuiza SL" como absorbida, con fecha 6 de abril de 2016, en la p谩ginaweb corporativa de la sociedad "World Duty Free Group SA", www.worlddutyfreegroup.com. Datos registrales. T 20644 , F 217, S 8,H M 365571, I/A 12M (11.04.16).

12 de Abril de 2016
Ceses/Dimisiones. Consejero: ARIAS-SALGADO MONTALVO RAFAEL;NADAL RUBIO FERNANDO;CREIGHTON FREDERICKROBERT;JIMENEZ BLANCO CARRILLO DE ALBORNOZ DAVID MARIA;OLIVERA MASSO PABLO. Secretario: OLIVERA MASSOPABLO. Presidente: JIMENEZ BLANCO CARRILLO DE ALBORNOZ DAVID MARIA. Nombramientos. Consejero: DIAZ GONZALEZJULIAN. Presidente: DIAZ GONZALEZ JULIAN. Cons.Del.Man: DIAZ GONZALEZ JULIAN. Consejero: MARIN MAS SARDALUIS;CASTRO BENITEZ PEDRO. Cons.Del.Man: MARIN MAS SARDA LUIS;CASTRO BENITEZ PEDRO;BAS LOSTAO PABLO.SecreNoConsj: OLIVERA MASSO PABLO. Datos registrales. T 32945 , F 128, S 8, H M 365571, I/A 70 ( 4.04.16).

25 de Enero de 2016
Ceses/Dimisiones. Presidente: ARIAS-SALGADO MONTALVO RAFAEL. Nombramientos. Presidente: JIMENEZ BLANCOCARRILLO DE ALBORNOZ DAVID MARIA. Datos registrales. T 32945 , F 128, S 8, H M 365571, I/A 69 (15.01.16).

02 de Noviembre de 2015
Revocaciones. Apoderado: GALLAGHER MASSO ROSA;GALLAGHER MASSO ROSA. Datos registrales. T 32945 , F 128, S 8, HM 365571, I/A 68 (23.10.15).

20 de Octubre de 2015
Nombramientos. Apoderado: CAROLYNE TEBBUT DENISE. Datos registrales. T 32945 , F 127, S 8, H M 365571, I/A 67 (8.10.15).

17 de Septiembre de 2015
Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 32945 , F 127, S 8, H M 365571, I/A 66 ( 9.09.15).

25 de Agosto de 2015
Revocaciones. Apoderado: DE RATO SALAZAR SIMPSON AURORA MARIA. Datos registrales. T 32945 , F 127, S 8, H M 365571,I/A 65 (17.08.15).

08 de Abril de 2015
Revocaciones. Apoderado: MONTERO TALLON DANIEL. Nombramientos. Apo.Man.Soli: CREIGHTON FREDERICKROBERT;PETCHEY MARTIN. Apo.Manc.: JIMENEZ-BLANCO CARRILLO DE ALBORNOZ DAVID MARIA;ANDRADES YUNTAEUGENIO;BAS LOSTAO PABLO;RODRIGUEZ-CARO MERINO JOSE MANUEL. Datos registrales. T 32945 , F 124, S 8, H M365571, I/A 64 (26.03.15).

06 de Abril de 2015
Otros conceptos: Emisi贸n de 63 t铆tulos m煤ltiples representativos de la totalidad de las acciones de la sociedad e inscripci贸n del actanotarial de identidad de firmas. Datos registrales. T 32945 , F 123, S 8, H M 365571, I/A 63 (25.03.15).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n