Actos BORME de Xarxa Europea De Transportes Barcelona Sl
22 de Diciembre de 2021Otros conceptos: JUZGADO SOCIAL 5 DE BARCELONA, RESOLUCION FIRME DE FECHA 1 DE JUNIO DE 2021, DECLARACIONDE INSOLVENCIA. Datos registrales. T 31491 , F 130, S 8, H B 191577, I/A 18 (13.12.21).
15 de Octubre de 2021Otros conceptos: JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO19/2021, AUTO FIRME DE FECHA 18/03/2021, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD Y CONCLUSIONDEL MISMO. Extinci贸n. Datos registrales. T 31491 , F 129, S 8, H B 191577, I/A 17 ( 7.10.21).
11 de Febrero de 2020Revocaciones. APOD.MANCOMU: FABREGAT MONTSERRAT JAIME;DOMENECH MINGOT MARIA LOURDES. Datosregistrales. T 31491 , F 129, S 8, H B 191577, I/A 16 ( 3.02.20).
23 de Diciembre de 2019Fe de erratas: En el BORME no.86/2017 y con referencia 193027 SE OMITIO EL CESE DEL AUDITOR SUPLENTE DON GONCALFABREGAS ALEGRET,SEGUN INS.15. Datos registrales. T 31491 , F 127, S 8, H B 191577, I/A 10 (28.04.17).
19 de Diciembre de 2019Otros conceptos: RECTIFICADA LA INSCRIPCION 10 POR CUANTO SE OMITIO EL CESE DEL AUDITOR SUPLENTE DONGONCAL FABREGAS ALEGRET. Datos registrales. T 31491 , F 129, S 8, H B 191577, I/A 15 (11.12.19).
08 de Octubre de 2019Nombramientos. APOD.MANCOMU: FABREGAT MONTSERRAT JAIME;DOMENECH MINGOT MARIA LOURDES. Datosregistrales. T 31491 , F 128, S 8, H B 191577, I/A 14 (30.09.19).
08 de Mayo de 2019Revocaciones. APODERAD.SOL: DOMENECH MINGOT MARIA LOURDES. Datos registrales. T 31491 , F 128, S 8, H B 191577,I/A 13 (26.04.19).
06 de Noviembre de 2018Modificaciones estatutarias. ADICION DEL ARTICULO 8 BIS A LOS ESTATUTOS SOCIALES. PRESTACIONES ACCESORIAS.Datos registrales. T 31491 , F 128, S 8, H B 191577, I/A 12 (25.10.18).
08 de Agosto de 2017Nombramientos. APODERAD.SOL: DOMENECH MINGOT MARIA LOURDES. Datos registrales. T 31491 , F 127, S 8, H B191577, I/A 11 ( 1.08.17).
09 de Mayo de 2017Revocaciones. AUDIT.CUENT.: FABREGAT VILA JOSE MARIA. Datos registrales. T 31491 , F 127, S 8, H B 191577, I/A 10(28.04.17).
20 de Enero de 2017Ampliaci贸n de capital. Capital: 57.660,00 Euros. Resultante Suscrito: 60.666,00 Euros. Datos registrales. T 31491 , F 126, S 8, H B191577, I/A 9 (12.01.17).
18 de Agosto de 2016Revocaciones. APODERADO: FERNANDEZ SANCHEZ JOSE MARIA. Datos registrales. T 31491 , F 126, S 8, H B 191577, I/A 8(10.08.16).
11 de Agosto de 2016Nombramientos. AUDIT.CUENT.: FABREGAT VILA JOSE MARIA. AUDITOR SUP.: FABREGAS ALEGRET GONCAL. Datosregistrales. T 31491 , F 126, S 8, H B 191577, I/A 7 ( 3.08.16).
13 de Abril de 2016Cambio de domicilio social. CL PERU,NUMERO 160, LOCAL PRIMERO (BARCELONA). Datos registrales. T 31491 , F 126, S 8,H B 191577, I/A 6 ( 6.04.16).
21 de Abril de 2014Nombramientos. APODERAD.SOL: DOMINGUEZ ARIAS ARANTXA. Datos registrales. T 31491 , F 125, S 8, H B 191577, I/A 5(10.04.14).
29 de Junio de 2012Cambio de domicilio social. CL BAC DE RODA Num.136 P.EN PTA.2 (BARCELONA). Datos registrales. T 31491 , F 125, S 8, H B191577, I/A 4 (19.06.12).