Buscador CIF Logo

Actos BORME Xerox Fabricacion Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Xerox Fabricacion Sa

Actos BORME Xerox Fabricacion Sa - A81541435

Tenemos registrados 17 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Xerox Fabricacion Sa con CIF A81541435

馃敊 Perfil de Xerox Fabricacion Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Xerox Fabricacion Sa

13 de Febrero de 2017
Ceses/Dimisiones. Consejero: CEBRIAN PARRONDO LAURA;FERNANDEZ GOMEZ RAMOS JAVIER. Secretario: FERNANDEZGOMEZ RAMOS JAVIER. Consejero: GARRUDO PACIOS CONCEPCION;GIL ELEJOSTE MARIA DE LOS ANGELES;BEAMONTEPUGA PALOMAPresidente: BEAMONTE PUGA PALOMA. Consejero: BERRIO RUIZ RICARDO. Con.Delegado: BERRIO RUIZRICARDO. Consejero: DIAZ ALVAREZ JUAN. Nombramientos. Liquidador: FERNANDEZ GOMEZ RAMOS JAVIER. Disoluci贸n.Voluntaria. Extinci贸n. Datos registrales. T 11467 , F 225, S 8, H M 180024, I/A 57 ( 2.02.17).

06 de Septiembre de 2016
Reelecciones. Consejero: DIAZ ALVAREZ JUAN. Datos registrales. T 11467 , F 224, S 8, H M 180024, I/A 56 (30.08.16).

08 de Octubre de 2015
Nombramientos. Consejero: BERRIO RUIZ RICARDO. Con.Delegado: BERRIO RUIZ RICARDO. Datos registrales. T 11467 , F224, S 8, H M 180024, I/A 55 ( 1.10.15).

05 de Agosto de 2015
Ceses/Dimisiones. Con.Delegado: BEAMONTE PUGA PALOMA. Reelecciones. Consejero: GIL ELEJOSTE MARIA DE LOSANGELES;BEAMONTE PUGA PALOMA. Presidente: BEAMONTE PUGA PALOMA. Datos registrales. T 11467 , F 223, S 8, H M180024, I/A 53 (29.07.15).

Modificaciones estatutarias. SE MODIFICAN LOS ARTICULOS 19潞 Y 20潞 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Datos registrales. T11467 , F 223, S 8, H M 180024, I/A 54 (29.07.15).

05 de Diciembre de 2014
Cambio de domicilio social. AVDA DE ARAGON 330 - EDIFICIO 6 (MADRID). Datos registrales. T 11467 , F 223, S 8, H M180024, I/A 52 (27.11.14).

05 de Agosto de 2013
Ceses/Dimisiones. Secretario: GIL ELEJOSTE MARIA DE LOS ANGELES. Nombramientos. Consejero: CEBRIAN PARRONDOLAURA;FERNANDEZ GOMEZ RAMOS JAVIER. Secretario: FERNANDEZ GOMEZ RAMOS JAVIER. Consejero: GARRUDO PACIOSCONCEPCION. Datos registrales. T 11467 , F 222, S 8, H M 180024, I/A 51 (27.07.13).

06 de Junio de 2012
Ceses/Dimisiones. Consejero: ZAGHOUANI DOURAID. Presidente: ZAGHOUANI DOURAID. Vicepresid.: BEAMONTE PUGAPALOMA. Nombramientos. Presidente: BEAMONTE PUGA PALOMA. Datos registrales. T 11467 , F 222, S 8, H M 180024, I/A 50(25.05.12).

07 de Junio de 2011
Ceses/Dimisiones. Consejero: DO CARMO DOS SANTOS GARCIA FILOMENA. Nombramientos. Consejero: DIAZ ALVAREZJUAN. Datos registrales. T 11467 , F 220, S 8, H M 180024, I/A 46 (24.05.11).

Nombramientos. Apoderado: BEAMONTE PUGA PALOMA NATALIA. Datos registrales. T 11467 , F 220, S 8, H M 180024, I/A 47(24.05.11).

Nombramientos. Apoderado: GIL ELEJOSTE MARIA ANGELES. Datos registrales. T 11467 , F 221, S 8, H M 180024, I/A 48(24.05.11).

Revocaciones. Apoderado: VILLEGAS SAN MARTIN SUSANA;MONASTERIO PEREZ DOMINGO;CORREDOR BARRANCOHORTENSIA. Datos registrales. T 11467 , F 222, S 8, H M 180024, I/A 49 (24.05.11).

23 de Marzo de 2011
Nombramientos. Apoderado: GIL ELEJOSTE MARIA DE LOS ANGELES. Datos registrales. T 11467 , F 220, S 8, H M 180024, I/A45 (11.03.11).

17 de Mayo de 2010
Ceses/Dimisiones. Consejero: DIAZ ALVAREZ JUAN;MEDINA DEL POZO CESAR. Presidente: DIAZ ALVAREZ JUAN. Secretario:MEDINA DEL POZO CESAR. Consejero: EVANS JOHN LESLIE. Con.Delegado: EVANS JOHN LESLIE. Vicepresid.: EVANS JOHNLESLIE. Nombramientos. Consejero: ZAGHOUANI DOURAID. Presidente: ZAGHOUANI DOURAID. Consejero: GIL ELEJOSTEMARIA ANGELES. Secretario: GIL ELEJOSTE MARIA ANGELES. Consejero: BEAMONTE PUGA PALOMA. Vicepresid.: BEAMONTEPUGA PALOMA. Consejero: DO CARMO DOS SANTOS GARCIA FILOMENA. Con.Delegado: BEAMONTE PUGA PALOMA. Datosregistrales. T 11467 , F 219, S 8, H M 180024, I/A 43 ( 5.05.10).

Modificaciones estatutarias. Fecha de Cierre de Ejercicio: 31/12.COMO CONSECUENCIA DEL CAMBIO DE LA FECHA DECIERRE DEL EJERCICIO SOCIAL, SE MODIFICA EL ARTICULO 29 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Datos registrales. T 11467 ,F 219, S 8, H M 180024, I/A 44 ( 6.05.10).

03 de Junio de 2009
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 11467 , F 219, S 8, H M 180024,I/A 42 (22.05.09).

01 de Junio de 2009
Cambio de domicilio social. C/ RIBERA DEL LOIRA 16-18 (MADRID). Datos registrales. T 11467 , F 218, S 8, H M 180024, I/A 41(20.05.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n