Actos BORME de Ximenez Corporation 2015 Sl
24 de Abril de 2023Ceses/Dimisiones. Secretario: JEFRASEMA 2020 SL. Nombramientos. Secretario: GROUXE CORPORATION SL. Datosregistrales. T 2459 , F 221, S 8, H CO 35652, I/A 13 (11.04.23).
12 de Agosto de 2022Ceses/Dimisiones. Consejero: JIMENEZ JIMENEZ MIGUEL MARIANO. Cons.Del.Sol: JIMENEZ JIMENEZ MIGUEL MARIANO.
15 de Marzo de 2022Nombramientos. Apoderado: JIMENEZ JIMENEZ JESUS MANUEL. Datos registrales. T 2457 , F 223, S 8, H CO 35652, I/A 10 (8.03.22).
27 de Mayo de 2021Nombramientos. Aud.C.Con.: EUDITA CYE AUDITORES SA. Datos registrales. T 2457 , F 223, S 8, H CO 35652, I/A 9 (19.05.21).
05 de Mayo de 2021Ceses/Dimisiones. Con.Delegado: JIMENEZ ROSALES FRANCISCO LEANDRO. Consejero: JIMENEZ ROSALES FRANCISCOLEANDRO. Presidente: JIMENEZ ROSALES FRANCISCO LEANDRO. Consejero: JIMENEZ ROSALES JESUS. Secretario: JIMENEZROSALES JESUS. Consejero: JIMENEZ ROSALES RAFAEL MIGUEL;JIMENEZ ROSALES JOSE PABLO. Nombramientos.Consejero: FRACAR 2020 SL. Presidente: FRACAR 2020 SL. Consejero: JEFRASEMA 2020 SL. Secretario: JEFRASEMA 2020 SL.Cons.Del.Sol: FRACAR 2020 SL. Consejero: JIMENEZ JIMENEZ MIGUEL MARIANO. Cons.Ejecuti: JIMENEZ JIMENEZ MIGUELMARIANO. Cons.Del.Sol: JIMENEZ JIMENEZ MIGUEL MARIANO. Consejero: GROUXE CORPORATION SL. Datos registrales. T2457 , F 222, S 8, H CO 35652, I/A 7 (26.04.21).
Nombramientos. Apoderado: REY BARBA ALBERTO. Datos registrales. T 2457 , F 222, S 8, H CO 35652, I/A 8 (26.04.21).
21 de Abril de 2021Modificaciones estatutarias. 6. Transmisi贸n de Acciones/Participaciones.-. 21. Organizaci贸n y de la administraci贸n de la sociedad.-.Datos registrales. T 2457 , F 139, S 8, H CO 35652, I/A 6 (14.04.21).
05 de Junio de 2020Nombramientos. Aud.C.Con.: C & P AUDITORES ANZUR SL. Datos registrales. T 2457 , F 139, S 8, H CO 35652, I/A 5 (26.05.20).
23 de Mayo de 2019Reelecciones. Auditor: C & P AUDITORES ANZUR SL. Datos registrales. T 2457 , F 138, S 8, H CO 35652, I/A 4 (16.05.19).
04 de Octubre de 2017Nombramientos. Auditor: EUDITA AUDITORES ANZUR SL. Datos registrales. T 2457 , F 138, S 8, H CO 35652, I/A 3 (27.09.17).
28 de Abril de 2015Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 24.03.15. Objeto social: a.- La adquisici贸n, venta, cesi贸n, inversi贸n, disfrute, administraci贸n,gesti贸n y negociaci贸n en general, como sociedad holding, de toda clase de participaciones sociales, acciones, o t铆tulos y valoresmobiliarios, cotizados en Bolsa u otros mercados o no, tanto nacionales como extranjeros, por cuen. Domicilio: CTRA CARRETERAMONTORO OSUNA Km 89 (PUENTE GENIL). Capital: 187.000,00 Euros. Nombramientos. Consejero: JIMENEZ ROSALESFRANCISCO LEANDRO. Presidente: JIMENEZ ROSALES FRANCISCO LEANDRO. Consejero: JIMENEZ ROSALES JESUS.Secretario: JIMENEZ ROSALES JESUS. Consejero: JIMENEZ ROSALES RAFAEL MIGUEL;JIMENEZ ROSALES PABLO. Datosregistrales. T 2457 , F 131, S 8, H CO 35652, I/A 1 (17.04.15).
Nombramientos. Con.Delegado: JIMENEZ ROSALES FRANCISCO LEANDRO. Datos registrales. T 2457 , F 138, S 8, H CO35652, I/A 2 (21.04.15).