Actos BORME de Xpo Transport Solutions Spain Sl
01 de Diciembre de 2023Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES S.L. Datos registrales. T 1176 , F 87, S 8, H S 11166, I/A 87 (22.11.23).
Revocaciones. Apo.Man.Soli: ORTIZ ROMERO CARLOS-MANUEL;LOSADA VEJO ZORAIDA. Nombramientos. Apo.Man.Soli:BELLO ALSINA ELENA;GUTIERREZ GONZALEZ DIEGO. Datos registrales. T 1176 , F 87, S 8, H S 11166, I/A 88 (24.11.23).
30 de Marzo de 2023Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES S.L. Datos registrales. T 1176 , F 87, S 8, H S 11166, I/A 86 (20.03.23).
12 de Enero de 2023Ceses/Dimisiones. Consejero: GOMEZ IZAGUIRRE LUIS ANGEL. Presidente: GOMEZ IZAGUIRRE LUIS ANGEL.Nombramientos. Consejero: MEAN NICOLAS PATRICK MARIE. Presidente: MEAN NICOLAS PATRICK MARIE. Reelecciones.Consejero: LEIVA TORRE TOMAS;MARTINEZ CALLEJA CRISTINA. SecreNoConsj: NARANJO GOZALO DAVID. Datos registrales.T 1176 , F 86, S 8, H S 11166, I/A 85 ( 4.01.23).
10 de Febrero de 2022Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES S.L. Datos registrales. T 1176 , F 86, S 8, H S 11166, I/A 84 ( 1.02.22).
09 de Septiembre de 2021Revocaciones. Apo.Sol.: RESA LOPEZ SARA. Datos registrales. T 1176 , F 86, S 8, H S 11166, I/A 83 ( 2.09.21).
11 de Junio de 2021Revocaciones. Apo.Sol.: BARROS MARTINEZ EDUARDO. Datos registrales. T 1176 , F 86, S 8, H S 11166, I/A 82 ( 2.06.21).
16 de Octubre de 2020Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES S.L. Datos registrales. T 1176 , F 86, S 8, H S 11166, I/A 81 ( 8.10.20).
24 de Febrero de 2020Revocaciones. Apo.Sol.: TORANZO MARTINEZ JAVIER;RAMIREZ PE脩O CESAR JAVIER;IZQUIERDO JIMENEZRAFAEL;IZQUIERDO JIMENEZ RAFAEL;TORANZO MARTINEZ JAVIER;RAMIREZ PE脩O CESAR JAVIER;ARAGON ARAGONMANUEL;ARROYO RAMOS FRANCISCO JAVIER;RODRIGUEZ SAHAGUN GONZALEZ MIGUEL ANGELApoderado: ANDERSONDAVID WILLIAM;ANDERSON DAVID WILLIAM;FRAILE CHARRI ELENA;FERNANDEZ DE BETHENCOURT PINO;ANDERSONDAVID WILLIAM. Apo.Man.Soli: DOMINGUEZ FERNANDEZ JOSE ANTONIO;BOOTH RACHE SARA;ASPDEN PETERGRAHAM;RODERICK EDWARD JOSEPH. Apo.Sol.: CANO GARCIA MARIA;LAZARO GONZALEZ RAQUEL. Datos registrales. T1176 , F 85, S 8, H S 11166, I/A 80 (12.02.20).
19 de Diciembre de 2019Nombramientos. Apo.Sol.: SAIZ VILLAR MARIA. Datos registrales. T 1176 , F 84, S 8, H S 11166, I/A 78 (10.12.19).
Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES S.L. Datos registrales. T 1176 , F 85, S 8, H S 11166, I/A 79 (10.12.19).
28 de Diciembre de 2018Ampliacion del objeto social. Intermediaci贸n y organizaci贸n del transporte, distribuci贸n, montaje, instalaci贸n y puesta en marcha deproductos de gama blanca y marron; mobiliario de interior y exterior; dispositivos multifunci贸n de oficinas; equipamientos de hosteler铆a,
19 de Diciembre de 2018Revocaciones. Apo.Man.Soli: NOVAL LLANO MARIA-JOSE. Nombramientos. Apo.Man.Soli: LOSADA VEJO ZORAIDA. Datosregistrales. T 1176 , F 83, S 8, H S 11166, I/A 76 (11.12.18).
07 de Noviembre de 2018Revocaciones. Apo.Sol.: LASALA URRUTICOECHEA JON KOLDOBITA. Nombramientos. Apo.Sol.: RESA LOPEZ SARA. Datosregistrales. T 1176 , F 83, S 8, H S 11166, I/A 75 (29.10.18).
30 de Agosto de 2018Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES S.L. Datos registrales. T 1176 , F 83, S 8, H S 11166, I/A 74 (22.08.18).
29 de Agosto de 2018Nombramientos. Apoderado: CARRETERO TOLEDO MERCEDES. Datos registrales. T 1176 , F 83, S 8, H S 11166, I/A 73(20.08.18).
08 de Agosto de 2018Revocaciones. Apo.Man.Soli: ARCE FERNANDEZ ANA. Nombramientos. Apo.Man.Soli: ANDRADES GIRON DAVID;PEREZORTIZ ARTURO. Datos registrales. T 1176 , F 82, S 8, H S 11166, I/A 72 (30.07.18).
24 de Abril de 2018Ceses/Dimisiones. Consejero: HEVIA GARCIA JUSTINO. Presidente: HEVIA GARCIA JUSTINO. Nombramientos. Consejero:GOMEZ IZAGUIRRE LUIS ANGEL. Presidente: GOMEZ IZAGUIRRE LUIS ANGEL. Reelecciones. Consejero: LEIVA TORRETOMAS;MARTINEZ CALLEJA CRISTINA. SecreNoConsj: NARANJO GOZALO DAVID. Datos registrales. T 1176 , F 82, S 8, H S11166, I/A 71 (16.04.18).
22 de Febrero de 2018Revocaciones. Apo.Man.Soli: ARCE FERNANDEZ ANA. Apo.Sol.: LOMBA GUTIERREZ JUAN JOSE;RABAGO SALCINESARACELI. Apo.Man.Soli: ARENAS GARCIA JOSE-LUIS;ORTIZ ROMERO CARLOS-MANUEL;ARCE FERNANDEZ ANA;MARTINEZCALLEJA CRISTINA. Apo.Sol.: LEIVA TORRE TOMAS;NARANJO GOZALO DAVID;FERNANDEZ VAL SARA;CABEZAS ARIASISABEL;ROCA LOPEZ ROBERTO MANUEL;LAZARO GONZALEZ RAQUEL;LOMBA GUTIERREZ JUAN JOSE;RABAGO SALCINESARACELI. Apo.Man.Soli: HEVIA GARCIA JUSTINO FRANCISCO. Apo.Sol.: ARENAS GARCIA JOSE-LUIS;LEIVA TORRETOMAS;NARANJO GOZALO DAVID. Apo.Man.Soli: NOVAL LLANO MARIA-JOSE. Apo.Sol.: BALAIRON ONRUBIA LUIS ALFREDO.Apo.Man.Soli: ARENAS GARCIA JOSE-LUIS;HEVIA GARCIA JUSTINO;MARTINEZ CALLEJA CRISTINA;ORTIZ ROMERO CARLOS-MANUEL;NOVAL LLANO MARIA-JOSE;ARCE FERNANDEZ ANA. Apo.Sol.: LEIVA TORRE TOMAS;NARANJO GOZALODAVID;FERNANDEZ VAL SARA;CABEZAS ARIAS ISABEL;BALAIRON ONRUBIA LUIS ALFREDO;ROCA LOPEZ ROBERTOMANUEL;LAZARO GONZALEZ RAQUEL;LOMBA GUTIERREZ JUAN JOSE;RABAGO SALCINES ARACELI. Apo.Man.Soli: ALLICAHERNANDEZ JESUS. Apo.Sol.: LASALA URRUTICOECHEA JON KOLDOBITA. Apoderado: CANO GARCIA MARIA.Nombramientos. Apo.Man.Soli: MARSILI MASSIMO;MARTINEZ CALLEJA CRISTINA;ARENAS GARCIA JOSE-LUIS;ORTIZROMERO CARLOS-MANUEL;NOVAL LLANO MARIA-JOSE;ARCE FERNANDEZ ANA;ALLICA HERNANDEZ JESUS. Apo.Sol.:LEIVA TORRE TOMAS;NARANJO GOZALO DAVID;LASALA URRUTICOECHEA JON KOLDOBITA;FERNANDEZ VALSARA;CABEZAS ARIAS ISABEL;BALAIRON ONRUBIA LUIS ALFREDO;CANO GARCIA MARIA;ROCA LOPEZ ROBERTOMANUEL;LAZARO GONZALEZ RAQUEL;BARROS MARTINEZ EDUARDO;LOMBA GUTIERREZ JUAN JOSE;RABAGO SALCINESARACELI. Datos registrales. T 1115 , F 225, S 8, H S 11166, I/A 70 (15.02.18).
20 de Abril de 2017Nombramientos. Apoderado: CANO GARCIA MARIA. Datos registrales. T 1115 , F 225, S 8, H S 11166, I/A 69 (10.04.17).
16 de Febrero de 2017Revocaciones. Apo.Sol.: CANO GARCIA MARIA. Datos registrales. T 1115 , F 224, S 8, H S 11166, I/A 67 ( 6.02.17).
Nombramientos. Apo.Sol.: LASALA URRUTICOECHEA JON KOLDOBITA. Datos registrales. T 1115 , F 224, S 8, H S 11166, I/A68 ( 7.02.17).
14 de Junio de 2016Ceses/Dimisiones. Consejero: ARENAS GARCIA JOSE-LUIS. Nombramientos. Consejero: MARTINEZ CALLEJA CRISTINA.Reelecciones. Consejero: HEVIA GARCIA JUSTINO;LEIVA TORRE TOMAS. Presidente: HEVIA GARCIA JUSTINO. SecreNoConsj:NARANJO GOZALO DAVID. Datos registrales. T 1115 , F 224, S 8, H S 11166, I/A 66 ( 7.06.16).
31 de Marzo de 2016Nombramientos. Apo.Man.Soli: ALLICA HERNANDEZ JESUS. Datos registrales. T 1115 , F 223, S 8, H S 11166, I/A 65 (23.03.16).
24 de Diciembre de 2015Revocaciones. Apo.Man.Soli: GOMEZ IZAGUIRRE LUIS ANGEL;ARENAS GARCIA JOSE-LUIS;ORTIZ ROMERO CARLOS-MANUEL. Apo.Sol.: LEIVA TORRE TOMAS;NARANJO GOZALO DAVID;FERNANDEZ VAL SARA;CABEZAS ARIASISABEL;RODRIGUEZ MANCHADO MARIA;LAZARO GONZALEZ RAQUEL;RODRIGUEZ FERNANDEZ JUAN IGNACIO;MARTINEZLOPEZ LUIS ROBERTO;LOMBA GUTIERREZ JUAN JOSE;MARTINEZ CALLEJA CRISTINA.Apo.Man.Soli: GOMEZ IZAGUIRRELUIS ANGEL. Apo.Sol.: RODRIGUEZ MANCHADO MARIA;RODRIGUEZ FERNANDEZ JUAN IGNACIO;MARTINEZ LOPEZ LUISROBERTO. Nombramientos. Apo.Man.Soli: ARENAS GARCIA JOSE-LUIS;HEVIA GARCIA JUSTINO;MARTINEZ CALLEJACRISTINA;ORTIZ ROMERO CARLOS-MANUEL;NOVAL LLANO MARIA-JOSE;ARCE FERNANDEZ ANA. Apo.Sol.: LEIVA TORRETOMAS;NARANJO GOZALO DAVID;FERNANDEZ VAL SARA;CABEZAS ARIAS ISABEL;BALAIRON ONRUBIA LUISALFREDO;CANO GARCIA MARIA;ROCA LOPEZ ROBERTO MANUEL;LAZARO GONZALEZ RAQUEL;LOMBA GUTIERREZ JUANJOSE;RABAGO SALCINES ARACELI. Datos registrales. T 1115 , F 221, S 8, H S 11166, I/A 64 (17.12.15).