Actos BORME de Ybarra Y Serret Sl
09 de Diciembre de 2021Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 125/2013. FIRME: Si, Fecha de resoluci贸n 29/10/2020. Auto de conclusi贸n delconcurso. Insuficiencia de la masa activa. Juzgado: num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 3 DE MADRID. Juez: JORGEMONTULL URQUIJO. Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 125/2013. Fecha de resoluci贸n 21/01/2019. Revocaci贸n deadministradores concursales. Juzgado: num. 0 JUZGADO MERCANTIL 3 DE MADRID. Juez: DON JESUS ALEMANY EGUIDAZUMONTULL URQUIJO. Administrador Concursal. Fecha 29/10/2020, NIF/CIF 02511983S. VAZQUEZ TORRES ANGEL LUIS.Extinci贸n. Datos registrales. T 29075 , F 112, S 8, H M 215365, I/A 29 (30.11.21).
04 de Julio de 2017Ampliaci贸n de capital. Capital: 147.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 307.104,00 Euros. Datos registrales. T 29075 , F 110, S 8,H M 215365, I/A 26 (26.06.17).
20 de Junio de 2016Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 205.603,20 Euros. Resultante Suscrito: 27.104,00 Euros. Ampliaci贸n de capital. Capital:133.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 160.104,00 Euros. Datos registrales. T 29075 , F 109, S 8, H M 215365, I/A 25 (10.06.16).
05 de Mayo de 2016Nombramientos. Apoderado: BONET YBARRA INES. Datos registrales. T 29075 , F 108, S 8, H M 215365, I/A 24 (27.04.16).
17 de Marzo de 2016Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 125/2013. FIRME: Si, Fecha de resoluci贸n 15/09/2014. Sentencia de aprobaci贸n delconvenio. Juzgado: num. 3 JUZGADO MERCA贸NTIL DE MADRID. Juez: ANTONIO PEDREIRA GONZALEZ.- Resoluciones: SEAPRUEBA EL CONVENIO ACEPTADO POR LA JUNTA DE ACREEDORES.- Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal125/2013. FIRME: Si, Fecha de resoluci贸n 15/09/2014. Auto de formaci贸n de la secci贸n de calificaci贸n. Juzgado: num. 3 JUZGADOMERCA贸NTIL DE MADRID. Juez: ANTONIO PEDREIRA GONZALEZ. Resoluciones: SE ABRE LA SECCION 6& DE CALIFICACION.-Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 125/2013. Fecha de resoluci贸n 19/06/2013. Revocaci贸n de administradoresconcursales. Juzgado: num. 3 JUZGADO MERCA贸NTIL DE MADRID. Juez: DON JESUS ALEMANY EGUIDAZU. AdministradorConcursal. Fecha 15/09/2014, NIF/CIF 02511983S. VAZQUEZ TORRES ANGEL LUIS. Datos registrales. T 29075 , F 106, S 8, H M215365, I/A 23 ( 7.03.16).
15 de Octubre de 2014Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 125/2013. FIRME: No, Fecha de resoluci贸n 27/05/2014. Auto de apertura de la fase deconvenio. Juzgado: num. 3 JUZGADO MERCANTIL DE MADRID. Juez: DON ANTONIO PEDREIRA GONZALEZ. Resoluciones:MANDAMIENTO POR EL QUE SE DECLARA FINALIZADA LA FASE COMUN DEL PROCEDIMIENTO, SE ABRE LA FASE DECONVENIO, SE ADMITE A TRAMITE LA PROPUESTA DE CONVENIO Y SE CONVOCA JUNTA DE ACREEDORES A CELEBRAREL DIA 3 DE JULIO DE 2014, A LAS 12:30 EN LA SALA DEL JUZGADO. Datos registrales. T 29075 , F 106, S 8, H M 215365, I/A B( 7.10.14).
11 de Julio de 2013Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 125/2013. FIRME: No, Fecha de resoluci贸n 19/06/2013. Auto de declaraci贸n deconcurso. Voluntario. Juzgado: num. 3 JUZGADO MERCA贸NTIL DE MADRID. Juez: DON JESUS ALEMANY EGUIDAZU. Situaci贸nconcursal. Procedimiento concursal 125/2013. Fecha de resoluci贸n 19/06/2013. Nombramiento de administradores. Juzgado: num. 3JUZGADO MERCA贸NTIL DE MADRID. Juez: DON JESUS ALEMANY EGUIDAZU. Administrador Concursal. Fecha 19/06/2013,NIF/CIF 02511983S. VAZQUEZ TORRES ANGEL LUIS. Datos registrales. T 29075 , F 106, S 8, H M 215365, I/A A ( 3.07.13).
02 de Agosto de 2012Ceses/Dimisiones. Consejero: YBARRA MENCOS MARIA DEL PERPETUO SOCORRO. Cons.Del.Sol: YBARRA MENCOS MARIADEL PERPETUO SOCORRO. Consejero: BONET MADURGA ANTONIO JAVIER. Presidente: BONET MADURGA ANTONIO JAVIER.Cons.Del.Sol: BONET MADURGA ANTONIO JAVIER. Consejero: DIEZ DE LOS RIOS LUIS. Cons.Del.Sol: DIEZ DE LOS RIOS LUIS.Consejero: MENCOS VALDES TERESA;PAREJA-OBREGON RUANO CARMEN. Secretario: YBARRA MENCOS MARIA DELPERPETUO SOCORRO. Nombramientos. Adm. Unico: YBARRA MENCOS MARIA DEL PERPETUO SOCORRO. Modificacionesestatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administrador 煤nico. Datos registrales. T 29075 ,F 104, S 8, H M 215365, I/A 21 (23.07.12).
Nombramientos. Apoderado: BONET MADURGA ANTONIO JAVIER. Datos registrales. T 29075 , F 104, S 8, H M 215365, I/A 22(23.07.12).
16 de Noviembre de 2011Ceses/Dimisiones. Consejero: BONET YBARRA INES. Secretario: BONET YBARRA INES. Nombramientos. Consejero: PAREJA-OBREGON RUANO CARMEN. Secretario: YBARRA MENCOS MARIA DEL PERPETUO SOCORRO. Ampliaci贸n de capital.Capital: 14.063,40 Euros. Resultante Suscrito: 232.707,20 Euros. Datos registrales. T 13292 , F 79, S 8, H M 215365, I/A 20 (2.11.11).
02 de Noviembre de 2011Ampliaci贸n de capital. Capital: 18.150,20 Euros. Resultante Suscrito: 218.643,80 Euros. Datos registrales. T 13292 , F 78, S 8, HM 215365, I/A 18 (20.10.11).
Revocaciones. Apoderado: FERNANDEZ GASSET PABLO FRANCISCO. Datos registrales. T 13292 , F 79, S 8, H M 215365, I/A19 (20.10.11).
19 de Agosto de 2011Revocaciones. Apoderado: ROSADO CORRAL MARIA LUISA. Datos registrales. T 13292 , F 78, S 8, H M 215365, I/A 17 (2.08.11).
17 de Febrero de 2011Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ GASSET PABLO FRANCISCO. Datos registrales. T 13292 , F 77, S 8, H M 215365, I/A16 ( 8.02.11).
14 de Enero de 2011Nombramientos. Apoderado: ROSADO CORRAL MARIA LUISA. Datos registrales. T 13292 , F 77, S 8, H M 215365, I/A 15 (4.01.11).
03 de Enero de 2011Ampliaci贸n de capital. Capital: 35.218,60 Euros. Resultante Suscrito: 200.493,60 Euros. Modificaciones estatutarias. Art铆culo delos estatutos: 5. Capital.-. Datos registrales. T 13292 , F 776, S 8, H M 215365, I/A 14 (22.12.10).
30 de Diciembre de 2010Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: YBARRA MENCOS MARIA DEL PERPETUO SOCORRO;BONET MADURGA ANTONIO JAVIER.Nombramientos. Consejero: YBARRA MENCOS MARIA DEL PERPETUO SOCORRO. Cons.Del.Sol: YBARRA MENCOS MARIADEL PERPETUO SOCORRO. Consejero: BONET MADURGA ANTONIO JAVIER. Presidente: BONET MADURGA ANTONIO JAVIER.Cons.Del.Sol: BONET MADURGA ANTONIO JAVIER. Consejero: DIEZ DE LOS RIOS LUIS. Cons.Del.Sol: DIEZ DE LOS RIOS LUIS.Consejero: MENCOS VALDES TERESA;BONET YBARRA INES. Secretario: BONET YBARRA INES. Modificaciones estatutarias.Cambio del Organo de Administraci贸n: Administradores solidarios a Consejo de administraci贸n. Datos registrales. T 13292 , F 76, S8, H M 215365, I/A 13 (17.12.10).
13 de Diciembre de 2010Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: YBARRA MENCOS SOCORRO;SERRET DE MURGA PILAR. Nombramientos. Adm. Solid.:YBARRA MENCOS MARIA DEL PERPETUO SOCORRO;BONET MADURGA ANTONIO JAVIER. Modificaciones estatutarias.Cambio del Organo de Administraci贸n: Administradores mancomunados a Administradores solidarios. Datos registrales. T 13292 , F76, S 8, H M 215365, I/A 12 (29.11.10).
11 de Noviembre de 2010Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: YBARRA MENCOS SOCORRO;SERRET DE MURGA PILAR. Nombramientos. Adm. Mancom.:YBARRA MENCOS SOCORRO;SERRET DE MURGA PILAR. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n:Administradores solidarios a Administradores mancomunados. Datos registrales. T 13292 , F 75, S 8, H M 215365, I/A 11 (29.10.10).
28 de Enero de 2010Cambio de domicilio social. C/ TAJO 53, POLIGONO INDUSTRIAL LAS ACACIAS (MEJORADA DEL CAMPO). Datos registrales.T 13292 , F 75, S 8, H M 215365, I/A 10 (18.01.10).