Actos BORME de Younexa Spain Sl
24 de Octubre de 2023Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: QUIMICER SL. ENDEKA HOLDCO SPAIN SOCIEDAD LIMITADA. ENDEKACERAMICS SL. Datos registrales. T 1907, L 1467, F 9, S 8, H CS 2145, I/A 136 (17.10.23).
21 de Agosto de 2023Nombramientos. Apo.Sol.: AGRAMUNT LERMA JOSE VICENTE;RIBERA LLORACH JUAN MANUEL. Datos registrales. T 1842, L1402, F 125, S 8, H CS 2145, I/A 129 (10.08.23).
Revocaciones. Apoderado: VACAS CORREDOR CARLOS JAVIER. Nombramientos. Apo.Sol.: VACAS CORREDOR CARLOSJAVIER. Datos registrales. T 1842, L 1402, F 126, S 8, H CS 2145, I/A 130 (10.08.23).
Revocaciones. Apo.Sol.: PEINADO GARCIA ALEJANDRO;NIETO RANERO JOSE MANUEL;NIETO RANERO JOSEMANUEL;GARZO CALATAYUD ROSANNA. Nombramientos. Apo.Sol.: PEINADO GARCIA ALEJANDRO;NIETO RANERO JOSEMANUEL;GARZO CALATAYUD ROSANNA. Datos registrales. T 1842, L 1402, F 127, S 8, H CS 2145, I/A 131 (10.08.23).
Revocaciones. Apo.Sol.: CABEDO LANUZA MARIA. Nombramientos. Apo.Sol.: BOSCA WATTS WENDY;CASTELLET GOMEZRAUL;CARRION DORADO JOSE ANTONIO;CABEDO LANUZA MARIA. Datos registrales. T 1907, L 1467, F 6, S 8, H CS 2145, I/A132 (10.08.23).
Nombramientos. Apo.Sol.: PARRA BORRAS PASCUAL JOSE. Datos registrales. T 1907, L 1467, F 8, S 8, H CS 2145, I/A 133(10.08.23).
Nombramientos. Apo.Sol.: MANRIQUE NAVARRO JOSE. Datos registrales. T 1907, L 1467, F 8, S 8, H CS 2145, I/A 134(10.08.23).
Nombramientos. Apo.Sol.: NACHER SILVESTRE FRANCISCO JOSE. Datos registrales. T 1907, L 1467, F 9, S 8, H CS 2145, I/A135 (10.08.23).
Revocaciones. Apoderado: MANRIQUE NAVARRO JOSE. Datos registrales. T 1907, L 1467, F 8, S 8, H CS 2145, I/A 134 b(10.08.23).
17 de Agosto de 2023Revocaciones. Apo.Sol.: SANCHEZ-PERAL SANCHEZ VICENTE-JOSE;SANCHEZ-PERAL SANCHEZ VICENTE-JOSE;SANCHEZ-PERAL SANCHEZ VICENTE-JOSE. Nombramientos. Apo.Sol.: SANCHEZ-PERAL SANCHEZ VICENTE-JOSE. Datos registrales.T 1842, L 1402, F 124, S 8, H CS 2145, I/A 128 ( 9.08.23).
21 de Junio de 2023Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: Modificado el art铆culo 4潞 de los Estatutos Sociales por cambio de domiciliosocial. Cambio de domicilio social. CTRA CABANES VALL D'ALBA Km 4 (VALL D'ALBA). Datos registrales. T 1842, L 1402, F124, S 8, H CS 2145, I/A 127 (14.06.23).
15 de Marzo de 2023Revocaciones. Apo.Sol.: BUER CHRIS;ROCABERT CRUZ MARTA;MESTRE GINER BORJA. Apoderado: TORTAJADA GIRBESJOSE;MALLEN BLASCO JOAQUIN VICENTE;TORTAJADA GIRBES JOSE. Apo.Sol.: RODRIGO SANZ JULIA. Datos registrales. T1842, L 1402, F 12, S 8, H CS 2145, I/A 126 ( 8.03.23).
14 de Diciembre de 2022Otros conceptos: Se inscribe el CAMBIO DE DURACION del PLAZO DEL ADMINISTRADOR y la RETRIBUCION al 贸rgano deadministraci贸n y MODIFICADO el art铆culo 20 de los Estatutos Sociales Datos registrales. T 1842, L 1402, F 12, S 8, H CS 2145, I/A125 ( 5.12.22).
30 de Noviembre de 2022Nombramientos. Apo.Sol.: CABEDO LANUZA MARIA. Datos registrales. T 1842, L 1402, F 12, S 8, H CS 2145, I/A 124 (23.11.22).
27 de Octubre de 2022Nombramientos. Apo.Sol.: SANCHEZ-PERAL SANCHEZ VICENTE-JOSE. Datos registrales. T 1842, L 1402, F 11, S 8, H CS2145, I/A 123 (20.10.22).
02 de Septiembre de 2022Nombramientos. Apo.Sol.: PEINADO GARCIA ALEJANDRO;NIETO RANERO JOSE MANUEL;GARZO CALATAYUDROSANNA;SANCHEZ-PERAL SANCHEZ VICENTE-JOSE. Datos registrales. T 1842, L 1402, F 11, S 8, H CS 2145, I/A 122 1
18 de Agosto de 2022Ceses/Dimisiones. Consejero: SANCHEZ-PERAL SANCHEZ VICENTE-JOSE;BLASCO FUENTES ANTONIO;BAGAN VARGASVICENTE ANTONIO. Presidente: BLASCO FUENTES ANTONIO. SecreNoConsj: ECHENIQUE SANJURJO MANUEL. VsecrNoConsj:TORRECILLAS POWER ELIZABETH. Nombramientos. Adm. Unico: NITRUR DE BOR SL. Otros conceptos: Cambio del Organode Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administrador 煤nico. Datos registrales. T 1842, L 1402, F 11, S 8, H CS 2145, I/A121 (10.08.22).
28 de Julio de 2022Nombramientos. Apoderado: TORTAJADA GIRBES JOSE. Datos registrales. T 1842, L 1402, F 10, S 8, H CS 2145, I/A 120(20.07.22).
11 de Febrero de 2022Ceses/Dimisiones. Consejero: BANDIERA DANIELE. Nombramientos. Consejero: SANCHEZ-PERAL SANCHEZ VICENTE-JOSE.Datos registrales. T 1842, L 1402, F 10, S 8, H CS 2145, I/A 119 ( 4.02.22).
15 de Noviembre de 2021Ceses/Dimisiones. Auditor: DELOITTE SL. Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datosregistrales. T 1842, L 1402, F 10, S 8, H CS 2145, I/A 118 ( 5.11.21).
18 de Octubre de 2021Nombramientos. Apoderado: MANRIQUE NAVARRO JOSE. Datos registrales. T 1842, L 1402, F 8, S 8, H CS 2145, I/A 113 (8.10.21).
Nombramientos. Apoderado: VACAS CORREDOR CARLOS JAVIER. Datos registrales. T 1842, L 1402, F 8, S 8, H CS 2145, I/A114 ( 8.10.21).
Nombramientos. Apoderado: TORTAJADA GIRBES JOSE. Datos registrales. T 1842, L 1402, F 9, S 8, H CS 2145, I/A 115 (8.10.21).
Ceses/Dimisiones. Con.Delegado: BANDIERA DANIELE. Revocaciones. Apoderado: MU脩OZ JUAN RENE-EDUARDO;CASTILLOARTETA ANGEL. Apo.Manc.: BAUER CRISTOPH;VAN DEL WILT GERRIT JACOBUS. Apoderado: GARCIA SAINZ JULIO;VAN DERWILT GERT;FERRO FINCO IRELAND LIMITED. Apo.Manc.: MU脩OZ JUAN RENE-EDUARDO. Apoderado: MANRIQUE NAVARROJOSE;MARTINEZ GARRIGA JUAN CARLOS;MANRIQUE NAVARRO JOSE;NOELIA SEGURA MARZA. Apo.Manc.: MU脩OZ JUANRENE-EDUARDO;MANRIQUE NAVARRO JOSE;CASTILLO ARTETA ANGEL;CASTILLO ARTETA ANGEL;MANRIQUE NAVARROJOSE;NOELIA SEGURA MARZA. Apo.Sol.: SEGURA MARZA NOELIA. Apoderado: MARZA CASAS JOSE ANTONIO. Apo.Sol.:VACAS CORREDOR CARLOS JAVIER. Apo.Manc.: MU脩OZ JUAN RENE-EDUARDO. Apo.Sol.: MU脩OZ JUAN RENE-EDUARDO.Datos registrales. T 1842, L 1402, F 9, S 8, H CS 2145, I/A 117 ( 8.10.21).
Nombramientos. Apoderado: MALLEN BLASCO JOAQUIN VICENTE. Datos registrales. T 1842, L 1402, F 9, S 8, H CS 2145, I/A116 ( 8.10.21).
22 de Julio de 2021Modificaciones estatutarias. INCLUSION ARTICULO 5BIS. Datos registrales. T 1842, L 1402, F 8, S 8, H CS 2145, I/A 112(15.07.21).