Actos BORME de Yugureda Sl
02 de Abril de 2014Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: INVESTARILONTE SL. Representan: SILVA NAVARRETE JUAN JOSE. Nombramientos.Liquidador: INVESTARILONTE SL. Representan: SILVA NAVARRETE JUAN JOSE. Disoluci贸n. Voluntaria. Extinci贸n. Datosregistrales. T 21451 , F 213, S 8, H M 381492, I/A 18 (25.03.14).
08 de Marzo de 2012Revocaciones. Apo.Sol.: RUMBO RAMOS GERMAN;CASTILLO ELIZALDE CARLOS;BARRENENGOA FERNANDEZ IGNACIO.Datos registrales. T 21451 , F 212, S 8, H M 381492, I/A 17 (28.02.12).
20 de Febrero de 2012Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 3.665.493,88 Euros. Resultante Suscrito: 16.660,06 Euros. Reducci贸n de capital.Importe reducci贸n: 1.692,01 Euros. Resultante Suscrito: 14.968,05 Euros. Otros conceptos: SE HAN REFUNDIDO LOSESTATUTOS SOCIALES. Datos registrales. T 21451 , F 211, S 8, H M 381492, I/A 16 ( 8.02.12).
02 de Febrero de 2012Ceses/Dimisiones. Consejero: BARRENENGOA FERNANDEZ IGNACIO;CARLOS CASTILLO ELIZALDE;RUMBO RAMOSGERMAN. Presidente: RUMBO RAMOS GERMAN. SecreNoConsj: MONTERO ROMERO ISRAEL. Nombramientos. Representan:SILVA NAVARRETE JUAN JOSE. Adm. Unico: INVESTARILONTE SL. Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 24.Administraci贸n y Representacion.-. Datos registrales. T 21451 , F 211, S 8, H M 381492, I/A 15 (20.01.12).
31 de Enero de 2012Ceses/Dimisiones. Consejero: CALLE SANTOS EUSEBIO JAVIER. SecreNoConsj: SANGRO GOMEZ ACEBO PEDRO.Revocaciones. Apoderado: LAFUENTE LESTON RAMON;URIA ALGORA CESAR;RUMBO RAMOS GERMAN;RICOY LUVIANOMARTIN;RICOY LUVIANO MARTIN;RUMBO RAMOS GERMAN;CASTILLO ELIZALDE CARLOS;RICOY LUVIANO MARTIN;URIAALGORA CESAR;GOMEZ GARCIA OSCAR;QUEMADA SAENZ-BADILLO JORGE;RUMBO RAMOS GERMAN. Nombramientos.SecreNoConsj: MONTERO ROMERO ISRAEL. Apo.Sol.: RUMBO RAMOS GERMAN;CASTILLO ELIZALDECARLOS;BARRENENGOA FERNANDEZ IGNACIO. Cambio de domicilio social. C/ GENERAL MARTINEZ CAMPOS 51(MADRID). Datos registrales. T 21451 , F 209, S 8, H M 381492, I/A 14 (18.01.12).
05 de Abril de 2010Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 392.795,07 Euros. Resultante Suscrito: 3.682.153,94 Euros. Datos registrales. T 21451 ,F 208, S 8, H M 381492, I/A 13 (22.03.10).
24 de Marzo de 2010Reelecciones. Aud.C.Con.: DELOITTE SL. Datos registrales. T 21451 , F 208, S 8, H M 381492, I/A 12 (10.03.10).
01 de Diciembre de 2009Ceses/Dimisiones. Consejero: RICOY LUVIANO MARTIN;GOMEZ GARCIA OSCAR;QUEMADA SAENZ DE BADILLOSJORGE;RUMBO RAMOS GERMAN. Presidente: RICOY LUVIANO MARTIN. Nombramientos. Consejero: BARRENENGOAFERNANDEZ IGNACIO;CALLE SANTOS EUSEBIO JAVIER;CARLOS CASTILLO ELIZALDE;RUMBO RAMOS GERMAN. Presidente:RUMBO RAMOS GERMAN. Datos registrales. T 21451 , F 208, S 8, H M 381492, I/A 11 (19.11.09).
17 de Marzo de 2009Ceses/Dimisiones. Consejero: URIA ALGORA CESAR. Datos registrales. T 21451 , F 207, S 8, H M 381492, I/A 10 ( 4.03.09).