Actos BORME de Zagros Sports Sa
05 de Septiembre de 2023Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 662.199,92 Euros. Resultante Suscrito: 405.466,68 Euros. Datos registrales. T 24908 , F9, S 8, H M 163130, I/A 37 (29.08.23).
31 de Mayo de 2023Nombramientos. Apoderado: WISNIEWSKA AGNIESZKA;ANCELY MACIAS MARIA DE LAS NIEVES;ARESPACOCHAGA LLOPIZBEATRIZ TRINIDAD. Datos registrales. T 24908 , F 9, S 8, H M 163130, I/A 36 (24.05.23).
22 de Febrero de 2022Revocaciones. Apoderado: HORTAL GONZALEZ FELIX IGNACIO;HORTAL GONZALEZ FELIX IGNACIO. Datos registrales. T24908 , F 9, S 8, H M 163130, I/A 35 (15.02.22).
09 de Diciembre de 2020Nombramientos. Apo.Sol.: FARHANGI SIOSHANSI RAMESH. Datos registrales. T 24908 , F 7, S 8, H M 163130, I/A 34 (30.11.20).
31 de Julio de 2020Reelecciones. Adm. Unico: FARHANGI RAMIN. Datos registrales. T 24908 , F 7, S 8, H M 163130, I/A 33 (24.07.20).
10 de Diciembre de 2018Revocaciones. Auditor: UHY FAY & CO AUDITORES CONSULTORES SL. Datos registrales. T 24908 , F 7, S 8, H M 163130, I/A32 (30.11.18).
28 de Diciembre de 2017Revocaciones. Apoderado: RAMIREZ ROBLEDANO CARLOS JAVIER;RAMIREZ ROBLEDANO CARLOS JAVIER.Nombramientos. Apo.Man.Soli: WISNIEWSKA AGNIESZKA. Datos registrales. T 24908 , F 6, S 8, H M 163130, I/A 31 (20.12.17).
18 de Agosto de 2017Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 204.628,48 Euros. Resultante Suscrito: 1.196.903,52 Euros. Reducci贸n de capital.Importe reducci贸n: 583.515,36 Euros. Resultante Suscrito: 613.388,16 Euros. Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 454.278,44 Euros.Desembolsado: 454.278,44 Euros. Resultante Suscrito: 1.067.666,60 Euros. Resultante Desembolsado: 1.067.666,60 Euros. Datosregistrales. T 24908 , F 5, S 8, H M 163130, I/A 30 ( 9.08.17).
06 de Febrero de 2017Nombramientos. Auditor: UHY FAY & CO AUDITORES CONSULTORES SL. Datos registrales. T 24908 , F 4, S 8, H M 163130, I/A29 (26.01.17).
13 de Diciembre de 2016Nombramientos. Apoderado: HORTAL GONZALEZ FELIX-IGNACIO;ANCELY MACIAS MARIA DE LASNIEVES;ARESPACOCHAGA LLOPIZ BEATRIZ TRINIDAD;RAMIREZ ROBLEDANO CARLOS JAVIER. Datos registrales. T 24908 ,F 4, S 8, H M 163130, I/A 28 (30.11.16).
17 de Febrero de 2016Nombramientos. Apoderado: HORTAL GONZALEZ FELIX IGNACIO;ANCELY MACIAS MARIA DE LAS NIEVES;ARESPACOCHAGA
Revocaciones. Apoderado: ROUMIAN ALVAREZ JAN. Apo.Sol.: ROUMIAN ALVAREZ JAN. Apoderado: ROUMIAN ALVAREZJAN;ROUMIAN ALVAREZ JAN;ROUMIAN ALVAREZ JAN;ROUMIAN ALVAREZ JAN;ROUMIAN ALVAREZ JAN. Datos registrales. T24908 , F 3, S 8, H M 163130, I/A 27 (10.02.16).
18 de Agosto de 2015Reelecciones. Adm. Unico: FARHANGI RAMIN. Datos registrales. T 24908 , F 3, S 8, H M 163130, I/A 25 ( 7.08.15).
17 de Febrero de 2015Revocaciones. Apoderado: ROJAS FELIPE JOSE LUIS;ROJAS FELIPE JOSE LUIS;ROJAS FELIPE JOSE LUIS. Datos registrales.T 24908 , F 3, S 8, H M 163130, I/A 24 ( 9.02.15).
10 de Septiembre de 2014Nombramientos. Apoderado: WISNIEWSKA AGNIESZKA. Datos registrales. T 24908 , F 2, S 8, H M 163130, I/A 23 ( 1.09.14).
16 de Abril de 2013Nombramientos. Apoderado: MOTAZEDI FABRIDA. Datos registrales. T 24908 , F 2, S 8, H M 163130, I/A 22 ( 8.04.13).
11 de Septiembre de 2012Nombramientos. Apoderado: ROUMIAN ALVAREZ JAN. Datos registrales. T 24908 , F 1, S 8, H M 163130, I/A 21 (30.08.12).
25 de Octubre de 2010Reelecciones. Adm. Unico: FARHANGI RAMIN. Datos registrales. T 24908 , F 1, S 8, H M 163130, I/A 20 (13.10.10).
07 de Agosto de 2009Nombramientos. Apoderado: ROUMIAN ALVAREZ JAN. Datos registrales. T 24908 , F 1, S 8, H M 163130, I/A 19 (28.07.09).