Buscador CIF Logo

Actos BORME Zares-97 Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Zares-97 Sl

Actos BORME Zares-97 Sl - B50740331

Tenemos registrados 11 Actos BORME del Registro Mercantil de Zaragoza para Zares-97 Sl con CIF B50740331

馃敊 Perfil de Zares-97 Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Zaragoza

Actos BORME de Zares-97 Sl

17 de Diciembre de 2019
Revocaciones. Apo.Man.Soli: CUESTA LUNA JAVIER. Nombramientos. Apo.Man.Soli: MOLINA RODRIGUEZ MARIA. Datosregistrales. T 2168 , F 218, S 8, H Z 21828, I/A 15 (10.12.19).

13 de Febrero de 2017
Revocaciones. Apo.Man.Soli: LEGARRE LASAOSA NAIARA;BENEDE SALINAS BEATRIZ;OTAL FLOREZ MARTA;HOYASANDREVIS JOSE MANUEL;BLASCO ANTON ELENA. Nombramientos. Apo.Man.Soli: BENEDE SALINAS BEATRIZ;HOYASANDREVIS JOSE MANUEL;BLASCO ANTON ELENA;CUESTA LUNA JAVIER. Datos registrales. T 2168 , F 218, S 8, H Z 21828,I/A 14 ( 3.02.17).

08 de Febrero de 2016
Ceses/Dimisiones. Consejero: PRESENCIO FERNANDEZ ANTONIO;SANZ PORTOLES FELIPE;BARBANY BAILO ANTONIO.Secretario: PRESENCIO FERNANDEZ ANTONIO. Presidente: SANZ PORTOLES FELIPE. Con.Delegado: SANZ PORTOLES FELIPE.Nombramientos. Adm. Unico: COMPA脩IA INMOBILIARIA Y DE INVERSIONES SA. Otros conceptos: Cambio del Organo deAdministraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administrador 煤nico. Datos registrales. T 2168 , F 217, S 8, H Z 21828, I/A 13(28.01.16).

06 de Octubre de 2014
Nombramientos. Apoderado: HOYAS ANDREVIS JOSE MANUEL. Datos registrales. T 2168 , F 217, S 8, H Z 21828, I/A 11(26.09.14).

Revocaciones. Apo.Sol.: ASTRAIN LOSILLA MIGUEL MARIA. Datos registrales. T 2168 , F 217, S 8, H Z 21828, I/A 12 (26.09.14).

04 de Septiembre de 2014
Nombramientos. Apo.Man.Soli: LEGARRE LASAOSA NAIARA;BENEDE SALINAS BEATRIZ;OTAL FLOREZ MARTA;HOYASANDREVIS JOSE MANUEL;BLASCO ANTON ELENA. Datos registrales. T 2168 , F 217, S 8, H Z 21828, I/A 10 (26.08.14).

27 de Noviembre de 2012
Nombramientos. Apo.Man.Soli: PRADAS BERNE LORENA;BENEDE SALINAS BEATRIZ;OTAL FLOREZ MARTA;HOYASANDREVIS JOSE MANUEL;BLASCO ANTON ELENA. Datos registrales. T 2168 , F 217, S 8, H Z 21828, I/A 8 (15.11.12).

Revocaciones. Apo.Man.Soli: AZAGRA GARCIA MARIA ANTONIA. Datos registrales. T 2168 , F 217, S 8, H Z 21828, I/A 9(15.11.12).

12 de Marzo de 2012
Ceses/Dimisiones. Consejero: SANZ PORTOLES ALFONSO. Secretario: SANZ PORTOLES ALFONSO. Nombramientos.Consejero: PRESENCIO FERNANDEZ ANTONIO. Secretario: PRESENCIO FERNANDEZ ANTONIO. Datos registrales. T 2168 , F216, S 8, H Z 21828, I/A 7 (29.02.12).

05 de Octubre de 2011
Nombramientos. Apo.Man.Soli: PRADAS BERNE LORENA;BENEDE SALINAS BEATRIZ;AZAGRA GARCIA MARIAANTONIA;HOYAS ANDREVIS JOSE MANUEL;BLASCO ANTON ELENA. Datos registrales. T 2168 , F 216, S 8, H Z 21828, I/A 6(21.09.11).

18 de Marzo de 2010
Nombramientos. Apoderado: PRESENCIO FERNANDEZ ANTONIO. Datos registrales. T 2168 , F 215, S 8, H Z 21828, I/A 5 (4.03.10).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n