Actos BORME de Zelenza Telecom Solutions Sl
03 de Agosto de 2023Reelecciones. Auditor: AUDALIA NEXIA AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 31262 , F 224, S 8, H M 562759,I/A 34 (26.07.23).
31 de Octubre de 2022Revocaciones. Apo.Sol.: NAVACERRADA MARTIN MARIA BELEN;ANGULO BARRIOS MILAGROS;CORREDOR GALVEENRIQUE;RAMIREZ HERRAIZ ANTONIO;ATIENZA VALERO MARIA ASUNCION;RIOL BLANCO JUAN CARLOS. Apo.Man.Soli:PASTRANA ROLDAN JOSE ANGEL;DE SANTIAGO DOMIGUEZ ANA TERESA. Apo.Sol.: PASCUAL GARCIA ANGEL;TORRESTORRES CONSUELO. Datos registrales. T 31262 , F 224, S 8, H M 562759, I/A 33 (24.10.22).
11 de Octubre de 2022Nombramientos. Apoderado: PARGADA CAYUELA JOSE MIGUEL. Datos registrales. T 31262 , F 223, S 8, H M 562759, I/A 32 (4.10.22).
29 de Agosto de 2022Nombramientos. Auditor: AUDALIA NEXIA AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 31262 , F 223, S 8, H M562759, I/A 31 (22.08.22).
26 de Julio de 2021Nombramientos. Apo.Man.Soli: PASTRANA ROLDAN JOSE ANGEL;ANGULO BARRIOS MILAGROS. Datos registrales. T 31262 ,F 221, S 8, H M 562759, I/A 30 (19.07.21).
22 de Octubre de 2020Ampliaci贸n de capital. Capital: 250.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 500.000,00 Euros. Datos registrales. T 31262 , F 221, S 8,H M 562759, I/A 29 (15.10.20).
09 de Septiembre de 2020Revocaciones. Apoderado: GARCIA GONZALEZ JOSE LUIS;GARCIA GONZALEZ JOSE LUIS. Datos registrales. T 31262 , F 221,S 8, H M 562759, I/A 28 ( 2.09.20).
24 de Marzo de 2020Nombramientos. Apo.Sol.: RAMIREZ HERRAIZ ANTONIO;ATIENZA VALERO MARIA ASUNCION;RIOL BLANCO JUAN CARLOS.Apo.Man.Soli: PASTRANA ROLDAN JOSE ANGEL;DE SANTIAGO DOMIGUEZ ANA TERESA. Apo.Sol.: PASCUAL GARCIAANGEL;TORRES TORRES CONSUELO. Datos registrales. T 31262 , F 218, S 8, H M 562759, I/A 27 (17.03.20).
02 de Marzo de 2020Ampliaci贸n de capital. Capital: 150.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 250.000,00 Euros. Datos registrales. T 31262 , F 218, S 8,H M 562759, I/A 26 (24.02.20).
12 de Febrero de 2020Nombramientos. Apoderado: GARCIA GONZALEZ JOSE LUIS. Datos registrales. T 31262 , F 217, S 8, H M 562759, I/A 24 (5.02.20).
Nombramientos. Apo.Sol.: NAVACERRADA MARTIN MARIA BELEN;ANGULO BARRIOS MILAGROS;CORREDOR GALVEENRIQUE. Datos registrales. T 31262 , F 218, S 8, H M 562759, I/A 25 ( 5.02.20).
17 de Diciembre de 2019Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: BAJO LANZA ISIDORO;FERNANDEZ GONZALEZ JOSE. Nombramientos. Adm. Unico:FERNANDEZ GONZALEZ JOSE. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Administradores solidarios aAdministrador 煤nico. Datos registrales. T 31262 , F 216, S 8, H M 562759, I/A 22 (10.12.19).
Nombramientos. Apoderado: TRIGUERO GEA JOSE LUIS. Datos registrales. T 31262 , F 216, S 8, H M 562759, I/A 23 (10.12.19).
22 de Mayo de 2019Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 2.650.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 0,00 Euros. Ampliaci贸n de capital. Capital:100.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 100.000,00 Euros. Datos registrales. T 31262 , F 215, S 8, H M 562759, I/A 21 (14.05.19).
27 de Diciembre de 2018Ceses/Dimisiones. Auditor: AUREN AUDITORES SP SLP. Nombramientos. Auditor: AUDALIA NEXIA AUDITORES SL. Datosregistrales. T 31262 , F 214, S 8, H M 562759, I/A 20 (19.12.18).
13 de Diciembre de 2018Revocaciones. Apoderado: BARBON LOPEZ MANUEL. Datos registrales. T 31262 , F 214, S 8, H M 562759, I/A 19 ( 5.12.18).