Buscador CIF Logo

Actos BORME Zero Emissions Technologies Sa

¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Zero Emissions Technologies Sa

Actos BORME Zero Emissions Technologies Sa - A91620187

Tenemos registrados 28 Actos BORME del Registro Mercantil de Sevilla para Zero Emissions Technologies Sa con CIF A91620187

🔙 Perfil de Zero Emissions Technologies Sa
🛒 Comprar listado completo de Empresas de Sevilla

Actos BORME de Zero Emissions Technologies Sa

27 de Febrero de 2023
Situación concursal. Procedimiento concursal 804/2022. FIRME: Si, Fecha de resolución 10/11/2022. Auto de declaración deconcurso. Voluntario. Juzgado: num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 3 DE SEVILLA. Juez: JESUS GINES GABALDONCODESIDO. Resoluciones: practicada INSCRIPCION DE LA DECLARACION DE CONCURSO SIN MASA. Situación concursal.Procedimiento concursal 804/2022. FIRME: Si, Fecha de resolución 10/11/2022. Resoluciones acordando la intervención o suspensiónde las factultades de administración y disposición del concursado. Juzgado: num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 3 DESEVILLA. Juez: JESUS GINES GABALDON CODESIDO. Resoluciones: NO CONSTA. Datos registrales. T 5679 , F 213, S 8, H SE71864, I/A 38 (13.02.23).

20 de Julio de 2021
Otros conceptos: DESIGNADO DON JUAN PABLO LOPEZ BRAVO VELASCO, con D.N.I. número 50.694.706-S, comorepresentante persona física de "ABENGOA INNOVACION, SOCIEDAD ANONIMA", para el ejercicio del cargo de ésta última comoadministradora única de "ZERO EMISSIONS TECHNOLOGIES, SA".- Datos registrales. T 5679 , F 213, S 8, H SE 71864, I/A 37(12.07.21).

19 de Julio de 2021
Articulo 378.5 del Reglamento del Registro Mercantil. Justificacion de no aprobacion de cuentas del ejercicio 2019 mediantecertificacion del organo de administracion. Datos registrales. T 5679 , F 213, S 8, H SE 71864, I/A 36 ( 7.07.21).

22 de Abril de 2021
Nombramientos. Apoderado: RUIZ GARCIA CRISTINA. Datos registrales. T 5679 , F 212, S 8, H SE 71864, I/A 35 (14.04.21).

26 de Marzo de 2019
Nombramientos. Adm. Unico: ABENGOA INNOVACION SOCIEDAD ANONIMA. Datos registrales. T 5679 , F 212, S 8, H SE71864, I/A 34 (19.03.19).

07 de Septiembre de 2018
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: ABEINSA INGENIERIA Y CONSTRUCCION INDUSTRIAL SA. Datos registrales. T 5679 , F 212, S8, H SE 71864, I/A 33 (29.08.18).

11 de Septiembre de 2017
Revocaciones. Apo.Sol.: ARTILLO GRAU JULIO;GONZALEZ DOMINGUEZ ALFONSO;JIMENEZ AGUILAR MANUEL;ARTILLOGRAU JULIO. Apo.Manc.: GONZALEZ DOMINGUEZ ALFONSO;ARTILLO GRAU JULIO;JIMENEZ AGUILAR MANUEL;ARTILLOGRAU JULIO;JIMENEZ AGUILAR MANUEL;VERGARA LOPEZ ALBERTO;DE LA ROSA DORADO JUAN MANUEL;GONZALEZDOMINGUEZ ALFONSO;JIMENEZ AGUILAR MANUEL. Datos registrales. T 5679 , F 211, S 8, H SE 71864, I/A 32 (31.08.17).

22 de Junio de 2016
Ceses/Dimisiones. Consejero: GONZALEZ DOMINGUEZ ALFONSO;ALAMINOS ECHARRI DANIEL;DIAZ VAZQUEZ ANA RAQUEL.Presidente: GONZALEZ DOMINGUEZ ALFONSO. Secretario: ALAMINOS ECHARRI DANIEL. Nombramientos. Adm. Unico:ABEINSA INGENIERIA Y CONSTRUCCION INDUSTRIAL SA. Modificaciones estatutarias. MODIFICADOS todos los artículos delos Estatutos como consecuencia de su adaptación a la Ley de Sociedades de Capital.-. Artículo de los estatutos: Artículo 3º.Domicilio.- . Otros conceptos: Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único. Cambio dedomicilio social. CTRA DE LA ESCLUSA S/N - POLIGONO TORRECUELLAR (SEVILLA). Datos registrales. T 5679 , F 209, S 8, HSE 71864, I/A 31 (14.06.16).

30 de Diciembre de 2015
Ceses/Dimisiones. Consejero: DOMINGUEZ ABASCAL JOSE;GONZALEZ DOMINGUEZ ALFONSO. Presidente: GONZALEZDOMINGUEZ ALFONSO. Consejero: ALAMINOS ECHARRI DANIEL. Secretario: ALAMINOS ECHARRI DANIEL. Nombramientos.Consejero: GONZALEZ DOMINGUEZ ALFONSO;ALAMINOS ECHARRI DANIEL;DIAZ VAZQUEZ ANA RAQUEL. Presidente:GONZALEZ DOMINGUEZ ALFONSO. Secretario: ALAMINOS ECHARRI DANIEL. Datos registrales. T 5679 , F 208, S 8, H SE71864, I/A 30 (21.12.15).

15 de Abril de 2015
Revocaciones. Apo.Sol.: BALBOA LINARES SALVADOR;CORREA PORTILLO SANTIAGO. Apo.Manc.: GONZALEZ DOMINGUEZALFONSO;LAZARICH RAMIREZ MARIA. Apo.Man.Soli: GOMEZ GARCIA GONZALO;GONZALEZ DOMINGUEZ ALFONSO;ARTILLOGRAU JULIO;FERNANDEZ IBAÑEZ MARIA ELENA;VERGARA LOPEZ ALBERTO;DE LA ROSA DORADO JUANMANUEL;LAZARICH RAMIREZ MARIA. Nombramientos. Apo.Sol.: GOMEZ GARCIA GONZALO;ARTILLO GRAUJULIO;FERNANDEZ IBAÑEZ MARIA ELENA;FERNANDEZ IBAÑEZ MARIA ELENA;FERNANDEZ IBAÑEZ MARIAELENA;GONZALEZ DOMINGUEZ ALFONSO;GOMEZ GARCIA GONZALO;JIMENEZ AGUILAR MANUEL;GOMEZ GARCIAGONZALO;ARTILLO GRAU JULIO. Apo.Manc.: GONZALEZ DOMINGUEZ ALFONSO;GOMEZ GARCIA GONZALO;ARTILLO GRAUJULIO;JIMENEZ AGUILAR MANUEL;GOMEZ GARCIA GONZALO;FERNANDEZ IBAÑEZ MARIA ELENA;ARTILLO GRAUJULIO;JIMENEZ AGUILAR MANUEL;VERGARA LOPEZ ALBERTO;DE LA ROSA DORADO JUAN MANUEL. Apo.Sol.: BALBOALINARES SALVADOR;CORREA PORTILLO SANTIAGO. Apo.Manc.: GONZALEZ DOMINGUEZ ALFONSO;JIMENEZ AGUILARMANUEL. Datos registrales. T 5679 , F 204, S 8, H SE 71864, I/A 29 ( 6.04.15).

02 de Septiembre de 2014
Ceses/Dimisiones. Consejero: JIMENEZ-VELASCO MAZARIO MIGUEL ANGEL. Secretario: JIMENEZ-VELASCO MAZARIOMIGUEL ANGEL. Consejero: GONZALEZ DOMINGUEZ ALFONSO;DOMINGUEZ ABASCAL JOSE. Presidente: GONZALEZDOMINGUEZ ALFONSO. Nombramientos. Consejero: GONZALEZ DOMINGUEZ ALFONSO. Presidente: GONZALEZ DOMINGUEZALFONSO. Consejero: ALAMINOS ECHARRI DANIEL. Secretario: ALAMINOS ECHARRI DANIEL. Consejero: DOMINGUEZABASCAL JOSE. Datos registrales. T 5679 , F 204, S 8, H SE 71864, I/A 28 (21.08.14).

14 de Febrero de 2014
Nombramientos. Apo.Sol.: BALBOA LINARES SALVADOR;CORREA PORTILLO SANTIAGO. Apo.Manc.: GOMEZ GARCIAGONZALO;FERNANDEZ IBAÑEZ MARIA ELENA. Datos registrales. T 5679 , F 203, S 8, H SE 71864, I/A 27 ( 4.02.14).

09 de Diciembre de 2013
Nombramientos. Apo.Sol.: BECERRA SANCHEZ JAVIER. Datos registrales. T 5679 , F 202, S 8, H SE 71864, I/A 26 (29.11.13).

24 de Mayo de 2013
Revocaciones. Apo.Man.Soli: MALO MONTORO NURIA. Apo.Manc.: RODRIGUEZ-IZQUIERDO SERRANO EMILIO;GONZALEZDOMINGUEZ ALFONSO. Apo.Man.Soli: GOMEZ GARCIA GONZALO;GONZALEZ DOMINGUEZ ALFONSO;ARTILLO GRAUJULIO;LAZARICH RAMIREZ MARIA. Nombramientos. Apo.Man.Soli: GOMEZ GARCIA GONZALO;GONZALEZ DOMINGUEZALFONSO;ARTILLO GRAU JULIO;FERNANDEZ IBAÑEZ MARIA ELENA;VERGARA LOPEZ ALBERTO;DE LA ROSA DORADOJUAN MANUEL;LAZARICH RAMIREZ MARIA. Datos registrales. T 5250 , F 17, S 8, H SE 71864, I/A 25 (14.05.13).

13 de Marzo de 2013
Desembolso de dividendos pasivos. Desembolsado: 45.150,00 Euros. Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos:MODIFICACION DEL ARTICULO 5º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Datos registrales. T 5250 , F 17, S 8, H SE 71864, I/A 24 (4.03.13).

26 de Julio de 2012
Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 5250 , F 17, S 8, H SE 71864, I/A 23 (11.07.12).

21 de Marzo de 2012
Reelecciones. Auditor: PRICE WATERHOUSE COOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 5250 , F 16, S 8, H SE 71864, I/A22 ( 8.03.12).

15 de Marzo de 2012
Nombramientos. Apo.Man.Soli: GOMEZ GARCIA GONZALO;GONZALEZ DOMINGUEZ ALFONSO;ARTILLO GRAUJULIO;LAZARICH RAMIREZ MARIA. Datos registrales. T 5250 , F 13, S 8, H SE 71864, I/A 20 ( 2.03.12).

14 de Marzo de 2012
Nombramientos. Apo.Sol.: BALBOA LINARES SALVADOR;CORREA PORTILLO SANTIAGO. Apo.Manc.: GONZALEZ DOMINGUEZALFONSO;LAZARICH RAMIREZ MARIA. Datos registrales. T 5250 , F 16, S 8, H SE 71864, I/A 21 ( 2.03.12).

24 de Febrero de 2012
Ceses/Dimisiones. Consejero: GONZALEZ DOMINGUEZ ALFONSO. Presidente: GONZALEZ DOMINGUEZ ALFONSO. Consejero:DOMINGUEZ ABASCAL JOSE;JIMENEZ-VELASCO MAZARIO MIGUEL ANGEL. Secretario: JIMENEZ-VELASCO MAZARIO MIGUELANGEL. Nombramientos. Consejero: GONZALEZ DOMINGUEZ ALFONSO;DOMINGUEZ ABASCAL JOSE;JIMENEZ-VELASCOMAZARIO MIGUEL ANGEL. Presidente: GONZALEZ DOMINGUEZ ALFONSO. Secretario: JIMENEZ-VELASCO MAZARIO MIGUELANGEL. Datos registrales. T 5250 , F 13, S 8, H SE 71864, I/A 19 (13.02.12).

11 de Julio de 2011
Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: 3. Domicilio.-. Cambio de domicilio social. C/ ENERGIA SOLAR 1 -CAMPUS PALMAS ALTAS (SEVILLA). Datos registrales. T 5250 , F 12, S 8, H SE 71864, I/A 18 (15.06.11).

24 de Mayo de 2011
Revocaciones. Apoderado: ORGE ALBERTE JUAN CARLOS;ORGE ALBERTE JUAN CARLOS. Nombramientos. Apoderado:MERINO CIUDAD ANTONIO. Datos registrales. T 5250 , F 10, S 8, H SE 71864, I/A 16 (11.05.11).

Revocaciones. Apo.Sol.: MEDINA LETRAN JOSE LUIS. Apo.Manc.: MEDINA LETRAN JOSE LUIS. Apo.Sol.: MEDINA LETRANJOSE LUIS;MEDINA LETRAN JOSE LUIS. Nombramientos. Apo.Man.Soli: MALO MONTORO NURIA. Apo.Manc.: RODRIGUEZ-IZQUIERDO SERRANO EMILIO;GONZALEZ DOMINGUEZ ALFONSO. Datos registrales. T 5250 , F 10, S 8, H SE 71864, I/A 17(11.05.11).

25 de Junio de 2010
Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: 4. Objeto.-. Ampliacion del objeto social. Ampliado a: podrá desarrollar, enrelación con el Cambio Climático y la sostenibilidad, actividades de formación, académica o no, en cualquier institución, así comoactividades de carácter divulgativo de las materias anteriormente referidas.- Datos registrales. T 4588 , F 108, S 8, H SE 71864, I/A15 (14.06.10).

20 de Mayo de 2010
Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ DOMINGUEZ ALFONSO. Datos registrales. T 4588 , F 108, S 8, H SE 71864, I/A 14 (7.05.10).

26 de Noviembre de 2009
Nombramientos. Apo.Sol.: MEDINA LETRAN JOSE LUIS. Datos registrales. T 4588 , F 108, S 8, H SE 71864, I/A 13 (16.11.09).

24 de Noviembre de 2009
Nombramientos. Auditor: PRICE WATERHOUSE COOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 4588 , F 107, S 8, H SE 71864,I/A 12 ( 4.11.09).

16 de Julio de 2009
Nombramientos. Apo.Manc.: JIMENEZ-VELASCO MAZARIO MIGUEL ANGEL;SANCHEZ FALCON AMANDO;GARCIA-QUILEZ

Utilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información