Actos BORME de Zeroemissions Carbon Trust Sociedad Anonima
03 de Noviembre de 2021Nombramientos. Apoderado: RUIZ GARCIA CRISTINA. Datos registrales. T 6191 , F 24, S 8, H SE 72662, I/A 30 (25.10.21).
20 de Julio de 2021Otros conceptos: DESIGNADO DON JUAN PABLO LOPEZ BRAVO VELASCO, con D.N.I. número 50.694.706-S, como
19 de Julio de 2021Articulo 378.5 del Reglamento del Registro Mercantil. Justificacion de no aprobacion de cuentas del ejercicio 2019 mediantecertificacion del organo de administracion. Datos registrales. T 6191 , F 24, S 8, H SE 72662, I/A 28 ( 7.07.21).
08 de Abril de 2019Nombramientos. Adm. Unico: ABENGOA INNOVACION SOCIEDAD ANONIMA. Datos registrales. T 6191 , F 23, S 8, H SE 72662,I/A 27 (29.03.19).
13 de Septiembre de 2018Fe de erratas: la inscripción 25ª con fecha de inscripción 29.8.2018, en realidad es la 26ª Datos registrales. T 6191 , F 23, S 8, H SE72662, I/A 26 (29.08.18).
07 de Septiembre de 2018Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: ABEINSA INGENIERIA Y CONSTRUCCION INDUSTRIAL SA. Datos registrales. T 6191 , F 23, S8, H SE 72662, I/A 25 (29.08.18).
26 de Mayo de 2016Ceses/Dimisiones. Consejero: GONZALEZ DOMINGUEZ ALFONSO;ALAMINOS ECHARRI DANIEL;GOMEZ GARCIA GONZALO.Presidente: GONZALEZ DOMINGUEZ ALFONSO. Secretario: ALAMINOS ECHARRI DANIEL. Nombramientos. Adm. Unico:ABEINSA INGENIERIA Y CONSTRUCCION INDUSTRIAL SA. Modificaciones estatutarias. MODIFICADOS la totalidad de losEstatutos Sociales de la sociedad, del 1º al 30º.-. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administración: Consejo deadministración a Administrador único. Datos registrales. T 5424 , F 64, S 8, H SE 72662, I/A 25 (16.05.16).
24 de Abril de 2015Revocaciones. Apo.Man.Soli: MALO MONTORO NURIA. Apo.Manc.: RODRIGUEZ-IZQUIERDO SERRANO EMILIO. Apo.Man.Soli:GOMEZ GARCIA GONZALO;GONZALEZ DOMINGUEZ ALFONSO;ARTILLO GRAU JULIO;LAZARICH RAMIREZ MARIA. Apo.Sol.:BALBOA LINARES SALVADOR;CORREA PORTILLO SANTIAGO. Apo.Manc.: GONZALEZ DOMINGUEZ ALFONSO;LAZARICHRAMIREZ MARIA. Nombramientos. Apo.Sol.: GOMEZ GARCIA GONZALO;GONZALEZ DOMINGUEZ ALFONSO;GOMEZ GARCIAGONZALO;MALO MONTORO NURIA;FERNANDEZ IBAÑEZ MARIA ELENA;FERNANDEZ IBAÑEZ MARIA ELENA;JIMENEZAGUILAR MANUEL;GOMEZ GARCIA GONZALO;MALO MONTORO NURIA. Apo.Manc.: GONZALEZ DOMINGUEZALFONSO;GOMEZ GARCIA GONZALO;MALO MONTORO NURIA;JIMENEZ AGUILAR MANUEL;GOMEZ GARCIAGONZALO;FERNANDEZ IBAÑEZ MARIA ELENA;MALO MONTORO NURIA;JIMENEZ AGUILAR MANUEL. Apo.Sol.: MALOMONTORO NURIA;MALO MONTORO NURIA;MALO MONTORO NURIA;BALBOA LINARES SALVADOR;CORREA PORTILLOSANTIAGO. Apo.Manc.: GONZALEZ DOMINGUEZ ALFONSO;JIMENEZ AGUILAR MANUEL. Datos registrales. T 5424 , F 61, S 8,H SE 72662, I/A 24 (13.04.15).
02 de Septiembre de 2014Ceses/Dimisiones. Consejero: JIMENEZ-VELASCO MAZARIO MIGUEL ANGEL. Secretario: JIMENEZ-VELASCO MAZARIOMIGUEL ANGEL. Consejero: GONZALEZ DOMINGUEZ ALFONSO;GOMEZ GARCIA GONZALO. Presidente: GONZALEZDOMINGUEZ ALFONSO. Nombramientos. Consejero: GONZALEZ DOMINGUEZ ALFONSO. Presidente: GONZALEZ DOMINGUEZALFONSO. Consejero: ALAMINOS ECHARRI DANIEL. Secretario: ALAMINOS ECHARRI DANIEL. Consejero: GOMEZ GARCIAGONZALO. Datos registrales. T 5424 , F 60, S 8, H SE 72662, I/A 23 (21.08.14).
14 de Abril de 2014Nombramientos. Apo.Sol.: BALBOA LINARES SALVADOR;CORREA PORTILLO SANTIAGO. Apo.Manc.: GOMEZ GARCIAGONZALO;MALO MONTORO NURIA. Datos registrales. T 5424 , F 60, S 8, H SE 72662, I/A 22 ( 7.04.14).
09 de Diciembre de 2013Nombramientos. Apo.Sol.: BECERRA SANCHEZ JAVIER. Datos registrales. T 5424 , F 59, S 8, H SE 72662, I/A 21 (29.11.13).
02 de Agosto de 2012Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 5424 , F 59, S 8, H SE 72662, I/A 20 (11.07.12).
21 de Marzo de 2012Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSE COOPERS SL. Datos registrales. T 5424 , F 58, S 8, H SE 72662, I/A 19 ( 9.03.12).
15 de Marzo de 2012Nombramientos. Apo.Man.Soli: GOMEZ GARCIA GONZALO;GONZALEZ DOMINGUEZ ALFONSO;ARTILLO GRAUJULIO;LAZARICH RAMIREZ MARIA. Datos registrales. T 5424 , F 55, S 8, H SE 72662, I/A 17 ( 2.03.12).
14 de Marzo de 2012Nombramientos. Apo.Sol.: BALBOA LINARES SALVADOR;CORREA PORTILLO SANTIAGO. Apo.Manc.: GONZALEZ DOMINGUEZ
24 de Febrero de 2012Ceses/Dimisiones. Consejero: GONZALEZ DOMINGUEZ ALFONSO. Presidente: GONZALEZ DOMINGUEZ ALFONSO. Consejero:JIMENEZ-VELASCO MAZARIO MIGUEL ANGEL. Secretario: JIMENEZ-VELASCO MAZARIO MIGUEL ANGEL. Consejero:RODRIGUEZ-IZQUIERDO SERRANO EMILIO;SANCHEZ FALCON AMANDO. Nombramientos. Consejero: GONZALEZDOMINGUEZ ALFONSO;GOMEZ GARCIA GONZALO;JIMENEZ-VELASCO MAZARIO MIGUEL ANGEL. Presidente: GONZALEZDOMINGUEZ ALFONSO. Secretario: JIMENEZ-VELASCO MAZARIO MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 5424 , F 55, S 8, H SE72662, I/A 16 (13.02.12).
31 de Octubre de 2011Desembolso de dividendos pasivos. Desembolsado: 45.150,00 Euros. Ampliación de capital. Suscrito: 65.000,00 Euros.Desembolsado: 65.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 125.200,00 Euros. Resultante Desembolsado: 125.200,00 Euros.Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: 5. Capital.-. Datos registrales. T 4619 , F 79, S 8, H SE 72662, I/A 15(11.10.11).
11 de Julio de 2011Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: 3. Domicilio.-. Cambio de domicilio social. C/ ENERGIA SOLAR 1 -CAMPUS PALMAS ALTAS (SEVILLA). Datos registrales. T 4619 , F 79, S 8, H SE 72662, I/A 14 (15.06.11).
24 de Mayo de 2011Revocaciones. Apoderado: ORGE ALBERTE JUAN CARLOS;ORGE ALBERTE JUAN CARLOS. Nombramientos. Apoderado:MERINO CIUDAD ANTONIO. Datos registrales. T 4619 , F 76, S 8, H SE 72662, I/A 12 (11.05.11).
Revocaciones. Apo.Man.Soli: MEDINA LETRAN JOSE LUIS. Apoderado: MEDINA LETRAN JOSE LUIS. Nombramientos.Apo.Man.Soli: MALO MONTORO NURIA. Apo.Manc.: RODRIGUEZ-IZQUIERDO SERRANO EMILIO;GONZALEZ DOMINGUEZALFONSO. Datos registrales. T 4619 , F 77, S 8, H SE 72662, I/A 13 (11.05.11).
20 de Mayo de 2010Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ DOMINGUEZ ALFONSO. Datos registrales. T 4619 , F 76, S 8, H SE 72662, I/A 11 (7.05.10).
24 de Noviembre de 2009Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSE COOPERS SL. Datos registrales. T 4619 , F 76, S 8, H SE 72662, I/A 10 (4.11.09).