Actos BORME de Zoetis Manufacturing & Research Spain Sociedad Limitada
07 de Agosto de 2023Revocaciones. Apo.Manc.: FERNANDA CAZAO APARICIO;MANOLIS KATSOUGKRIS. Nombramientos. Apo.Manc.: ILYASBELRHALI;CHIVER THAM. Datos registrales. T 3402 , F 166, S 8, H GI 10878, I/A 125 (31.07.23).
08 de Marzo de 2023Revocaciones. Apo.Man.Soli: GIOVANNI INTURRISI. Nombramientos. Apo.Man.Soli: JORGE MAMPEL SANCHEZ. Apo.Manc.:RICARD COSTA SUBIRA. Datos registrales. T 2854 , F 33, S 8, H GI 10878, I/A 124 ( 1.03.23).
06 de Marzo de 2023Revocaciones. Apo.Man.Soli: NURIA VILA ANTEQUERA. Apo.Manc.: JORDI FABREGAS GARRIGA. Nombramientos. Apo.Manc.:FERRAN FRIGOLA POCH;JAEL INDIRA OSORO. Datos registrales. T 2854 , F 33, S 8, H GI 10878, I/A 123 (27.02.23).
30 de Diciembre de 2022Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 2854 , F 33, S 8, H GI 10878, I/A 122 (22.12.22).
15 de Febrero de 2021Otros conceptos: Según Oficio de fecha 26/10/2020, expedido por el R. M. de Madrid, se ha constituido el depósito de las CuentasConsolidadas, ejercicio 2018/2019, con el número 75954, de fecha 10/08/2020, siendo la Sociedad dominante "PAH SPAIN SL".Datos registrales. T 2854 , F 33, S 8, H GI 10878, I/A NM3 ( 8.02.21).
26 de Enero de 2021Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 2854 , F 33, S 8, H GI 10878, I/A 121 (19.01.21).
27 de Enero de 2020Otros conceptos: Según Oficio de fecha 18/11/2019, expedido por el R. M. de Madrid, se ha constituido el depósito de las CuentasConsolidadas, ejercicio 2017/2018, con el número 221362, de fecha 07/11/2019, siendo la Sociedad dominante "PAH SPAIN SL".Datos registrales. T 2854 , F 33, S 8, H GI 10878, I/A NM2 (20.01.20).
25 de Octubre de 2018Ceses/Dimisiones. Consejero: FELIX HERNAEZ UGARTE. Presidente: FELIX HERNAEZ UGARTE. Consejero: GIOVANNIINTURRISI;MATTHEW EDWARD EVERHART. Secretario: MACARENA TOTI-LOMBARDOZZI FRANZI. Nombramientos. Adm.Unico: PAH SPAIN SL. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único.
21 de Agosto de 2018Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 2854 , F 32, S 8, H GI 10878, I/A 119 (14.08.18).
07 de Febrero de 2018Revocaciones. Apo.Sol.: MARC LLENAS BALLESTERO. Nombramientos. Apoderado: MONTSERRAT PEÑARROYA MARGARIT.Datos registrales. T 2854 , F 32, S 8, H GI 10878, I/A 118 (31.01.18).
09 de Enero de 2018Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 2854 , F 32, S 8, H GI 10878, I/A 117 ( 2.01.18).
20 de Septiembre de 2017Revocaciones. Apo.Manc.: MICHEL PAUL MARIA VERHOLEN;SERENE TAN YUNG WEE;FERNANDA CAZAO APARICIO.Nombramientos. Apo.Manc.: MICHEL PAUL MARIA VERHOLEN;FERNANDA CAZAO APARICIO;MANOLIS KATSOUGKRIS. Datosregistrales. T 2854 , F 31, S 8, H GI 10878, I/A 115 (13.09.17).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: NURIA VILA ANTEQUERA. Datos registrales. T 2854 , F 31, S 8, H GI 10878, I/A 116 (13.09.17).
20 de Febrero de 2017Ceses/Dimisiones. Consejero: BELEN ORIA ALMUDI;PIET SWARTELE. Nombramientos. Consejero: GIOVANNI
Ceses/Dimisiones. Secretario: JAVIER FERNANDEZ LUZURIAGA. Revocaciones. Apo.Man.Soli: BELEN ORIA ALMUDI. Apo.Sol.:JAVIER CARRASCAL SATRUSTEGUI. Nombramientos. Secretario: MACARENA TOTI-LOMBARDOZZI FRANZI. Apo.Man.Soli:GIOVANNI INTURRISI;RICARD COSTA SUBIRA. Apo.Manc.: MATTHEW EDWARD EVERHART;JORDI FABREGAS GARRIGA.Apoderado: MACARENA TOTI-LOMBARDOZZI FRANZI. Datos registrales. T 2854 , F 30, S 8, H GI 10878, I/A 114 (13.02.17).
23 de Enero de 2017Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 2854 , F 30, S 8, H GI 10878, I/A 112 (16.01.17).
05 de Diciembre de 2016Revocaciones. Apo.Man.Soli: PIET SWARTELE;BELEN ORIA ALMUDI;JOSEFINA PUIG CODINACH;RICARD COSTA SUBIRA.Apo.Sol.: ANTONI MARIA CASAMITJANA COROMINA;JAVIER CARRASCAL SATRUSTEGUI;ALICIA URNIZA HOSTENCH;PIETSWARTELE;SUSANA GONZALEZ VEIGA. Nombramientos. Apo.Man.Soli: MATTHEW EDWARD EVERHART;BELEN ORIAALMUDI;JORDI FABREGAS GARRIGA;RICARD COSTA SUBIRA. Apo.Sol.: MARC LLENAS BALLESTERO;SUSANA GONZALEZVEIGA;JAVIER CARRASCAL SATRUSTEGUI;ALICIA URNIZA HOSTENCH. Datos registrales. T 2854 , F 28, S 8, H GI 10878, I/A111 (28.11.16).
29 de Noviembre de 2016Revocaciones. Apo.Manc.: SCOTT HUNTER. Nombramientos. Apo.Sol.: JORDI FABREGAS GARRIGA. Datos registrales. T2854 , F 27, S 8, H GI 10878, I/A 110 (22.11.16).
23 de Febrero de 2016Revocaciones. Apo.Man.Soli: CONCEPCION PLUJA DARNE. Datos registrales. T 2854 , F 27, S 8, H GI 10878, I/A 109 (16.02.16).
02 de Octubre de 2015Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 2854 , F 27, S 8, H GI 10878, I/A 107 (25.09.15).
Revocaciones. Apo.Manc.: GABRIELA TURTOI. Datos registrales. T 2854 , F 27, S 8, H GI 10878, I/A 108 (25.09.15).
06 de Marzo de 2015Revocaciones. Apo.Man.Soli: VICENTE MORALES FERNANDEZ. Apo.Sol.: ANA GOMEZ ORTAS;ISIDORA TERCIADOBARCALA;PIEDAD GARRIDO LAMAS;ANA MONTERO FERNANDEZ. Nombramientos. Apo.Sol.: PIET SWARTELE;SUSANAGONZALEZ VEIGA. Datos registrales. T 2854 , F 26, S 8, H GI 10878, I/A 105 (26.02.15).
Revocaciones. Apo.Manc.: CAMILLA UDEN;SCOTT HUNTER;ASHLEY CORDOVA;BEATRIZ SALDIVAR;RACHEL JONES;HUIPINGJIANG. Nombramientos. Apo.Manc.: MICHEL PAUL MARIA VERHOLEN;SCOTT HUNTER;GABRIELA TURTOI;SERENE TANYUNG WEE;FERNANDA CAZAO APARICIO. Datos registrales. T 2854 , F 27, S 8, H GI 10878, I/A 106 (27.02.15).
29 de Diciembre de 2014Modificaciones estatutarias. Artículo 19.- La remuneración de los administradores será la que se derive, exclusivamente, de loscontratos que regulen sus relaciones laborales o profesionales con la Sociedad, y será ratificada anualmente por la Junta General deSocios. . Datos registrales. T 2854 , F 26, S 8, H GI 10878, I/A 104 (19.12.14).
05 de Agosto de 2014Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 2854 , F 26, S 8, H GI 10878, I/A 103 (29.07.14).
17 de Diciembre de 2013Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 2854 , F 26, S 8, H GI 10878, I/A 102 (10.12.13).
20 de Septiembre de 2013Nombramientos. Apo.Manc.: CAMILLA UDEN;SCOTT HUNTER;ASHLEY CORDOVA;BEATRIZ SALDIVAR;RACHELJONES;HUIPING JIANG. Datos registrales. T 2854 , F 25, S 8, H GI 10878, I/A 101 (13.09.13).
19 de Junio de 2013Ceses/Dimisiones. Secretario: VICENTE MORALES FERNANDEZ. Nombramientos. Secretario: JAVIER FERNANDEZLUZURIAGA. Datos registrales. T 2854 , F 25, S 8, H GI 10878, I/A 100 (12.06.13).
13 de Marzo de 2013Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio único: PAH SPAIN SL. Datos registrales. T 2854 , F 25, S 8, H GI 10878,I/A 99 ( 6.03.13).