Actos BORME de Zopi Sa
03 de Agosto de 2023Cambio de objeto social. LA ACTIVIDAD MOBILIARIA E INMOBILIARIA, SALVO LA SUJETA A LEGISLACION ESPECIAL, ASICOMO EL ASESORAMIENTO COMERCIAL O CONTABLE A PERSONAS FISICAS O JURIDICAS. LA PROMOCION INMOBILIARIADE TODO TIPO DE INMUEBLES, URBANOS... Datos registrales. T 22505 , F 72, S 8, H B 38115, I/A 18 (27.07.23).
16 de Marzo de 2023Cambio de domicilio social. CL DISSET Num.7 (CASTELLDEFELS). Datos registrales. T 22505 , F 72, S 8, H B 38115, I/A 17 (8.03.23).
09 de Febrero de 2022Revocaciones. ADM.SOLIDAR.: MORENILLA BONET MANUEL;BONET VIDAL MARIA CARMEN. Nombramientos. ADM.UNICO:MORENILLA BONET MANUEL. Datos registrales. T 22505 , F 72, S 8, H B 38115, I/A 16 ( 2.02.22).
10 de Noviembre de 2020Revocaciones. ADM.UNICO: MORENILLA BONET MANUEL. Nombramientos. ADM.SOLIDAR.: MORENILLA BONETMANUEL;BONET VIDAL MARIA CARMEN. Modificaciones estatutarias. MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 4,9,11 Y 12 DELOS ESTATUTOS SOCIALES Y ADICION A LOS MISMOS DEL ARTICULO 11 BIS. CAMBIO DE REGIMEN ADMINISTRATIVO.Datos registrales. T 22505 , F 71, S 8, H B 38115, I/A 15 ( 2.11.20).
28 de Enero de 2015Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 59.090,00 Euros. Desembolsado: 59.090,00 Euros. Resultante Suscrito: 510.090,00 Euros.Resultante Desembolsado: 510.090,00 Euros. Datos registrales. T 22505 , F 71, S 8, H B 38115, I/A 14 (19.01.15).
13 de Enero de 2015Revocaciones. ADM.UNICO: BONET VIDAL MARIA DEL CARMEN. Nombramientos. ADM.UNICO: MORENILLA BONETMANUEL. Datos registrales. T 22505 , F 70, S 8, H B 38115, I/A 13 ( 2.01.15).
27 de Enero de 2011Revocaciones. ADM.UNICO: MORENILLA BONET MANUEL. Nombramientos. ADM.UNICO: BONET VIDAL MARIA DELCARMEN. Modificaciones estatutarias. ART 11:DETERMINACION DEL SISTEMA RETRIBUTIVO DEL CARGO DEADMINISTRADOR. Datos registrales. T 22505 , F 70, S 8, H B 38115, I/A 12 (17.01.11).
27 de Enero de 2010Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 240,40 Euros. Desembolsado: 240,40 Euros. Resultante Suscrito: 450.999,48 Euros. ResultanteDesembolsado: 450.999,48 Euros. Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 0,52 Euros. Desembolsado: 0,52 Euros. Resultante Suscrito:451.000,00 Euros. Resultante Desembolsado: 451.000,00 Euros. Modificaciones estatutarias. MODIFICACION DEL VALORNOMINAL DE LAS ACCIONES Y RENUMERACION DE LAS MISMAS. Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas:EMATRENTA HOLDING SL. SAVIPOR SA. Datos registrales. T 22505 , F 65, S 8, H B 38115, I/A 11 (14.01.10).