Actos BORME de Zubizarreta Consulting Sl
27 de Octubre de 2020Otros conceptos: Se sustituye a Doña María Loinaz Alonso, como persona física representante de "ZUBIZARRETA CONSULTING,S.L.", para el ejercicio del cargo de Secretario no consejero del Consejo de Administración de la Compañía "HAZIBIDE, S.A.", por DoñaNaiara Alzola Liñares, con D.N.I. 72754008V.- Datos registrales. T 1693 , F 116, S 8, H VI 155, I/A 29 (14.10.20).
27 de Febrero de 2020Nombramientos. Apo.Sol.: POLO RIEGO MYRIAM;DIEZ BLANCO LAURA. Datos registrales. T 1588 , F 79, S 8, H VI 155, I/A 28 (7.02.20).
07 de Febrero de 2020Nombramientos. Apoderado: ZUBIZARRETA RIEGO MIKEL. Datos registrales. T 1588 , F 77, S 8, H VI 155, I/A 26 (23.01.20).
Nombramientos. Apo.Sol.: ESTEBAN HERNANDEZ XABIER;AMOROS PAGOLA ALBERTO;ALVAREZ JIMENEZ IGONE. Datosregistrales. T 1588 , F 78, S 8, H VI 155, I/A 27 (23.01.20).
03 de Abril de 2019Cambio de domicilio social. C/ SAN ANTONIO, Nº 2, BAJO.- (VITORIA-GASTEIZ). Datos registrales. T 1588 , F 77, S 8, H VI 155,I/A 25 (20.03.19).
23 de Marzo de 2018Otros conceptos: Se cesa a Doña Agueda Sáinz Lanchares, como persona física representante de "ZUBIZARRETA CONSULTING,S.L. ", la cual es Secretaria no consejera del Consejo de Administración de la sociedad "HAZIBIDE, S.A. ", y se nombra en sustituciónde la misma a Doña María Loinaz Alonso.- Datos registrales. T 1588 , F 77, S 8, H VI 155, I/A 24 ( 1.03.18).
01 de Diciembre de 2016Nombramientos. Apo.Sol.: POLO RIEGO MYRIAM;DIEZ BLANCO LAURA. Datos registrales. T 1588 , F 76, S 8, H VI 155, I/A 23(18.11.16).
16 de Septiembre de 2016Nombramientos. Apo.Sol.: ROMERO LLOP LUCIA;ADRIAN VICENT LIDIA. Datos registrales. T 1588 , F 76, S 8, H VI 155, I/A 22(19.08.16).
09 de Julio de 2015Nombramientos. Apoderado: ZUBIZARRETA RIEGO MIKEL. Datos registrales. T 833 , F 211, S 8, H VI 155, I/A 21 (26.06.15).
17 de Diciembre de 2014Revocaciones. Apoderado: ODRIOZOLA ZUBIA PEDRO MARIA;ALZOLA MARTINEZ DE ANTOÑANA AITOR JOSE. Datosregistrales. T 833 , F 211, S 8, H VI 155, I/A 20 ( 9.12.14).
27 de Noviembre de 2014Nombramientos. Apo.Sol.: FAYOS CRESPO JORGE;PONS CABALLERO ROBERTO;CABEDO GREGORI RODRIGO;MIRAVILLAVERDE JORGE ANGEL;RIOS MUÑOZ MARIA PILAR;PONS LLOVERAS MARCEL;SANCHEZ TRIADO PERE;RIBERASSANCHEZ PAULA;AUDIT-LEX ADMINISTRADORES CONCURSALES Y PERITOS S. Datos registrales. T 833 , F 210, S 8, H VI155, I/A 19 (10.11.14).
02 de Julio de 2013Reducción de capital. Importe reducción: 5.330,87 Euros. Resultante Suscrito: 42.749,13 Euros. Otros conceptos: Se renumeranlas participaciones sociales en que se divide el capital social de la compañía. Datos registrales. T 833 , F 209, S 8, H VI 155, I/A 18(18.06.13).
06 de Noviembre de 2009Ceses/Dimisiones. Presidente: ZUBIZARRETA URCELAY VICENTE. Consejero: ZUBIZARRETA URCELAYVICENTE;GOROSTEGUI ITURRIOZ FELIPE. Presidente: ZUBIZARRETA URCELAY VICENTE. Con.Delegado: ZUBIZARRETAURCELAY VICENTE. Consejero: ZUBIZARRETA URCELAY VICENTE;SAN MARTIN RUANA JESUS. Secretario: SAN MARTINRUANA JESUS. Nombramientos. Adm. Unico: ZUBIZARRETA URCELAY VICENTE. Modificaciones estatutarias. Cambio delOrgano de Administración: Consejo de administración a Administrador único. Otros conceptos: Modificados los artículos 13º y 29ºEstatutarios; y rectificada la numeración de los artículos Estatutarios que figuraban como 27º,27º y 28º, por la actual de 27º,28º y 29º.-Datos registrales. T 833 , F 208, S 8, H VI 155, I/A 17 (27.10.09).