Buscador CIF Logo

Actos BORME Zurbilan Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Zurbilan Sl

Actos BORME Zurbilan Sl - B59940122

Tenemos registrados 12 Actos BORME del Registro Mercantil de Barcelona para Zurbilan Sl con CIF B59940122

馃敊 Perfil de Zurbilan Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Barcelona

Actos BORME de Zurbilan Sl

25 de Octubre de 2023
Nombramientos. APOD.SOL/MAN: ESTRELLES DOMINGO MANUEL JESUS;MORCILLO RIPOLL ANABEL;ROMAGOSA CASULAMARIA CRISTINA;ROGER LOPPACHER JAVIER;GIRBAL TORRENTS LLUIS;RUIZ LORENZO NICOLAS. Datos registrales. T41916 , F 215, S 8, H B 23520, I/A 32 (17.10.23).

14 de Diciembre de 2021
Cambio de domicilio social. VIA AUGUSTA NUM.200 PLANTA 1 NORTE (BARCELONA). Datos registrales. T 41916 , F 215, S 8,H B 23520, I/A 31 ( 3.12.21).

02 de Diciembre de 2021
Revocaciones. APOD.MANCOMU: ESTRELLES DOMINGO MANUEL JESUS;RODRIGUEZ POUSA JOSE;ROGER LOPPACHERJAVIER;SAEZ SANCHEZ VICTOR. Datos registrales. T 41916 , F 215, S 8, H B 23520, I/A 30 (25.11.21).

28 de Abril de 2021
Nombramientos. APOD.SOL/MAN: ESTRELLES DOMINGO MANUEL JESUS;MORCILLO RIPOLL ANABEL;ROMAGOSA CASULAMARIA CRISTINA;ROGER LOPPACHER JAVIER;SAEZ SANCHEZ VICTOR;RUIZ LORENZO NICOLAS. Datos registrales. T 41916, F 214, S 8, H B 23520, I/A 29 (20.04.21).

22 de Noviembre de 2019
Revocaciones. ADM.CONJUNTO: ESPA脩A PIERRA CARMEN;CARLO MONTRUCCHIO BRAMBILLA. Nombramientos.ADM.UNICO: GALLARDO TORREDEDIA ANA. Modificaciones estatutarias. ADICION DEL ARTICULO 19 BIS A LOS ESTATUTOSSOCIALES. REMUNERACION DE LOS ADMINISTRADORES. Datos registrales. T 41916 , F 213, S 8, H B 23520, I/A 28 (14.11.19).

29 de Noviembre de 2018
Revocaciones. APODERADO: OLIVAN NAVARRO TERESA;ESCODA BIARNES TOMAS;CAZORLA AIGUABELLAJULIO;RODRIGUEZ POUSA JOSE;ROGER LOPPACHER JAVIER;SAEZ SANCHEZ VICTOR. APOD.MANCOMU: CAZORLAAIGUABELLA JULIO. Datos registrales. T 41916 , F 213, S 8, H B 23520, I/A 27 (21.11.18).

25 de Agosto de 2016
Nombramientos. APODERAD.SOL: ROMAGOSA CASULA CRISTINA. Datos registrales. T 41916 , F 213, S 8, H B 23520, I/A 26(18.08.16).

26 de Noviembre de 2014
Nombramientos. APOD.MANCOMU: CAZORLA AIGUABELLA JULIO;ESTRELLES DOMINGO MANUEL JESUS;RODRIGUEZPOUSA JOSE;ROGER LOPPACHER JAVIER;SAEZ SANCHEZ VICTOR. Datos registrales. T 41916 , F 212, S 8, H B 23520, I/A 25(18.11.14).

18 de Enero de 2011
Ampliaci贸n de capital. Capital: 232.623,06 Euros. Resultante Suscrito: 325.778,06 Euros. Datos registrales. T 41916 , F 211, S 8,H B 23520, I/A 24 ( 4.01.11).

17 de Junio de 2010
Nombramientos. APODERADO: GALLARDO TORREDEDIA ANA. Datos registrales. T 33080 , F 39, S 8, H B 23520, I/A 23 (4.06.10).

08 de Abril de 2010
Ampliaci贸n de capital. Capital: 3.005,00 Euros. Resultante Suscrito: 93.155,00 Euros. Cambio de objeto social.TENENCIA,DIRECCION Y GESTION DE LA PARTICIPACION EN OTRAS SOCIEDADES MEDIANTE LA CORRESPONDIENTEORGANIZACION DE MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES.ACTIVIDAD,PROMOCION Y NEGOCIO INMOBILIARIO, ETC. Fusi贸npor absorci贸n. Sociedades absorbidas: ESFINCO SL. Datos registrales. T 33080 , F 37, S 8, H B 23520, I/A 22 (25.03.10).

26 de Agosto de 2009
Otros conceptos: DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL,SOCIO UNICO:"DO脩A ANA GALLARDO TORREDEDIA". Datosregistrales. T 33080 , F 36, S 8, H B 23520, I/A 21 (17.08.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n