Buscador CIF Logo

Actos BORME Zyma Servicios Graficos Sll

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Zyma Servicios Graficos Sll

Actos BORME Zyma Servicios Graficos Sll - B20609327

Tenemos registrados 10 Actos BORME del Registro Mercantil de Guipuzcoa para Zyma Servicios Graficos Sll con CIF B20609327

馃敊 Perfil de Zyma Servicios Graficos Sll
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Guipuzcoa

Actos BORME de Zyma Servicios Graficos Sll

09 de Octubre de 2019
Revocaciones. Apo.Sol.: MINTEGUIAGA RUIZ JOSE ANTONIO. Nombramientos. Apoderado: BENITO LOBO JOSE LUIS. Datosregistrales. T 1681 , F 106, S 8, H SS 13932, I/A 17 (30.09.19).

15 de Octubre de 2018
Nombramientos. Apo.Sol.: BENITO LOBO JOSE LUIS;TERRONES GOMEZ JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 1681 , F 106, S8, H SS 13932, I/A 16 ( 4.10.18).

11 de Octubre de 2018
Ceses/Dimisiones. Consejero: BENITO LOBO JOSE LUIS;PIELAGO BARQUILLA FERMIN;TERRONES GOMEZ JOSEANTONIO;MINTEGUIAGA RUIZ JOSE ANTONIO;URDANGARIN CARRERA JUAN JOSE;MU脩OZ RAMOS JOSE ENRIQUE.Presidente: MINTEGUIAGA RUIZ JOSE ANTONIO. Secretario: MU脩OZ RAMOS JOSE ENRIQUE. Nombramientos. Consejero:MINTEGUIAGA RUIZ JOSE ANTONIO;TERRONES GOMEZ JOSE ANTONIO;MU脩OZ RAMOS JOSE ENRIQUE;PIELAGOBARQUILLA FERMIN;BENITO LOBO JOSE LUIS. Presidente: BENITO LOBO JOSE LUIS. Secretario: TERRONES GOMEZ JOSEANTONIO. Datos registrales. T 1681 , F 104, S 8, H SS 13932, I/A 14 ( 4.10.18).

Adaptaci贸n Ley 44/2015. Datos registrales. T 1681 , F 104, S 8, H SS 13932, I/A 15 ( 4.10.18).

25 de Agosto de 2015
Revocaciones. Apoderado: ALVAREZ GARCIA MARIA CONCEPCION. Apo.Sol.: ALVAREZ GARCIA MARIA CONCEPCION. Datosregistrales. T 1681 , F 104, S 8, H SS 13932, I/A 13 (12.08.15).

29 de Enero de 2015
Nombramientos. Apo.Sol.: MU脩OZ RAMOS JOSE ENRIQUE;MINTEGUIAGA RUIZ JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 1681 , F103, S 8, H SS 13932, I/A 12 (19.01.15).

04 de Diciembre de 2014
Ceses/Dimisiones. Consejero: IMAZ MU脩OZ RAFAEL;ALVAREZ GARCIA MARIA CONCEPCION. Presidente: IMAZ MU脩OZRAFAEL. Secretario: ALVAREZ GARCIA MARIA CONCEPCION. Nombramientos. Presidente: MINTEGUIAGA RUIZ JOSEANTONIO. Secretario: MU脩OZ RAMOS JOSE ENRIQUE. Datos registrales. T 1681 , F 103, S 8, H SS 13932, I/A 11 (26.11.14).

21 de Mayo de 2014
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: IMAZ MU脩OZ RAFAEL. Nombramientos. Consejero: IMAZ MU脩OZ RAFAEL;ALVAREZ GARCIAMARIA CONCEPCION;URDANGARIN CARRERA JUAN JOSE;MU脩OZ RAMOS JOSE ENRIQUE;MINTEGUIAGA RUIZ JOSEANTONIO;BENITO LOBO JOSE LUIS;PIELAGO BARQUILLA FERMIN;TERRONES GOMEZ JOSE ANTONIO. Presidente: IMAZMU脩OZ RAFAEL. Secretario: ALVAREZ GARCIA MARIA CONCEPCION. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo deAdministraci贸n: Administrador 煤nico a Consejo de administraci贸n. Datos registrales. T 1681 , F 102, S 8, H SS 13932, I/A 9(13.05.14).

Nombramientos. Apoderado: IMAZ MU脩OZ RAFAEL. Datos registrales. T 1681 , F 103, S 8, H SS 13932, I/A 10 (13.05.14).

02 de Febrero de 2011
Nombramientos. Apoderado: ALVAREZ GARCIA MARIA CONCEPCION. Datos registrales. T 1681 , F 102, S 8, H SS 13932, I/A 8(24.01.11).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n