Buscador CIF Logo

Actos BORME Activex Servicios Integrales Sa

¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Activex Servicios Integrales Sa

Actos BORME Activex Servicios Integrales Sa - A81114506

Tenemos registrados 21 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Activex Servicios Integrales Sa con CIF A81114506

🔙 Perfil de Activex Servicios Integrales Sa
🛒 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Activex Servicios Integrales Sa

17 de Julio de 2023
Revocaciones. Apo.Manc.: THIJS MARIA JOHANA C.;CORTINA DE LA HERRAN JULIAN EDUARDO;BARBA DIAZJAVIER;SANCHEZ BRAVO DEBORA;CASCON GALAN MARIA DEL MAR;PEREYRA LUJAN ANDREA BEATRIZ. Nombramientos.Apoderado: THIJS MARIA JOHANA C.;CORTINA DE LA HERRAN JULIAN EDUARDO;BARBA DIAZ JAVIER;SANCHEZ BRAVODEBORA;CASCON GALAN MARIA DEL MAR;PEREYRA LUJAN ANDREA BEATRIZ;RELAÑO MARTIN MARIA LAURA. Datosregistrales. T 29585 , F 9, S 8, H M 148738, I/A 49 (10.07.23).

21 de Marzo de 2023
Revocaciones. Apo.Manc.: BERROCAL VELASCO ARACELI;CORTINA DE LA HERRAN JULIAN EDUARDO;CAMPS GUERREROJOSE MARIA. Nombramientos. Apo.Manc.: THIJS MARIA JOHANA C.;CORTINA DE LA HERRAN JULIAN EDUARDO;BARBA DIAZJAVIER;SANCHEZ BRAVO DEBORA;CASCON GALAN MARIA DEL MAR;PEREYRA LUJAN ANDREA BEATRIZ. Datos registrales.T 29585 , F 8, S 8, H M 148738, I/A 48 (13.03.23).

07 de Febrero de 2023
Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: Modificar el artículo 2. Objeto social.-. Cambio de domicilio social. C/MADRID 58 2º (GETAFE). Cambio de objeto social. a) Servicios administrativos de todo tipo para oficinas, empresas y despachos,incluyendo los servicios de secretariado, recepción, conserjería y control de accesos, gestión y distribución de correo, valija ymensajería, vigilancia.. Datos registrales. T 29585 , F 7, S 8, H M 148738, I/A 46 (31.01.23).

Nombramientos. Apo.Sol.: HERRERO TEJEDOR ALGAR CARLOS. Datos registrales. T 29585 , F 8, S 8, H M 148738, I/A 47(31.01.23).

28 de Marzo de 2022
Revocaciones. Auditor: ADHOC AUDITORES SLP. Nombramientos. Auditor: VERAE AUDITORES SLP. Datos registrales. T29585 , F 7, S 8, H M 148738, I/A 45 (21.03.22).

16 de Diciembre de 2021
Revocaciones. Apoderado: GOMEZ SAIZ ROSARIO;GUTIERREZ GARCIA MARIA CRISTINA;GOMEZ SAIZ ROSARIO;FONSECAMAGANTO PILAR;LASAGA GILA DOLORES ANGELES;MUÑIZ GARCIA LUIS. Apo.Manc.: GUTIERREZ GARCIACRISTINA;LARTHA BELIEN NADINE LODEWIJK;FERRERAS ALONSO FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 29585 , F 7, S 8,H M 148738, I/A 44 ( 9.12.21).

13 de Febrero de 2020
Reelecciones. Auditor: ADHOC AUDITORES SLP. Datos registrales. T 29585 , F 7, S 8, H M 148738, I/A 43 ( 6.02.20).

08 de Agosto de 2019
Declaración de unipersonalidad. Socio único: ONE EYE LTD. Ceses/Dimisiones. Consejero: CREYF HERMAN HARRYPETER;AGIO SERVICIOS CENTRALIZADOS SA;THEBOOM CREYF MARIANNE GABRIELLE. Presidente: THEBOOM CREYFMARIANNE GABRIELLE. Con.Delegado: THEBOOM CREYF MARIANNE GABRIELLE. SecreNoConsj: HERRERO TEJEDOR ALGARCARLOS. Representan: THEBOOM CREYF MARIANNE GABRIELLE. Nombramientos. Adm. Unico: THEBOOM CREYFMARIANNE GABRIELLE. Modificaciones estatutarias. Modificacion y nueva redaacion de los articulos 15, 16, 17 y 21 y se deja sincontenido los articulos 19, 20 y 22 de los estatutos sociales. . Otros conceptos: Cambio del Organo de Administración: Consejo deadministración a Administrador único. Datos registrales. T 29585 , F 6, S 8, H M 148738, I/A 42 ( 1.08.19).

31 de Octubre de 2017
Nombramientos. Apoderado: CORTINA DE LA HERRAN JULIAN EDUARDO. Datos registrales. T 29585 , F 5, S 8, H M 148738,I/A 41 (23.10.17).

06 de Febrero de 2017
Reelecciones. Auditor: ADHOC AUDITORES SLP. Consejero: CREYF HERMAN HARRY PETER;AGIO SERVICIOSCENTRALIZADOS SA;THEBOOM CREYF MARIANNE GABRIELLE. Presidente: THEBOOM CREYF MARIANNE GABRIELLE.Con.Delegado: THEBOOM CREYF MARIANNE GABRIELLE. SecreNoConsj: HERRERO TEJEDOR ALGAR CARLOS. Representan:THEBOOM CREYF MARIANNE GABRIELLE. Datos registrales. T 29585 , F 4, S 8, H M 148738, I/A 40 (26.01.17).

07 de Abril de 2016
Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: 4. Domicilio.-. Cambio de domicilio social. GTA DE QUEVEDO 9 3º(MADRID). Datos registrales. T 29585 , F 4, S 8, H M 148738, I/A 39 (30.03.16).

03 de Junio de 2014
Revocaciones. Apoderado: BERROCAL VELASCO ARACELI;CORTINA DE LA HERRAN JULIAN EDUARDO;CAMPS GUERREROJOSE MARIA;GUTIERREZ GARCIA CRISTINA;RODRIGUEZ SANCHEZ ANGEL LUIS;BELIEN NADINE LODEWIJK MARTHA;DAVIDMARTIN SANCHEZ. Datos registrales. T 29585 , F 4, S 8, H M 148738, I/A 38 (26.05.14).

30 de Abril de 2014
Nombramientos. Apo.Manc.: BERROCAL VELASCO ARACELI;CORTINA DE LA HERRAN JULIAN EDUARDO;CAMPS GUERREROJOSE MARIA;GUTIERREZ GARCIA CRISTINA;LARTHA BELIEN NADINE LODEWIJK;RELAÑO MARTIN MARIA LAURA;FERRERASALONSO FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 29585 , F 3, S 8, H M 148738, I/A 37 (22.04.14).

02 de Abril de 2014
Nombramientos. Apoderado: CORTINA DE LA HERRAN JULIAN EDUARDO. Datos registrales. T 29585 , F 3, S 8, H M 148738,I/A 36 (25.03.14).

31 de Enero de 2014
Reelecciones. Auditor: ADHOC AUDITORES SLP. Datos registrales. T 29585 , F 2, S 8, H M 148738, I/A 35 (23.01.14).

09 de Julio de 2013
Ampliacion del objeto social. LAS ACTIVIDADES DESTINADAS A LA RECOLOCACION DE LAS PERSONAS TRABAJADORASQUE RESULTARAN EXCEDENTES EN PROCESOS DE REESTRUCTURACION EMPRESARIAL, EN LOS TERMINOS QUEAPARECEN ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVA DE APLICACION PARA LAS EMPRESAS DE RECOLOCACION. Datosregistrales. T 29585 , F 2, S 8, H M 148738, I/A 34 ( 1.07.13).

14 de Enero de 2013
Cambio de domicilio social. C/ MARIA DE MOLINA 37 8 (MADRID). Datos registrales. T 25585 , F 2, S 8, H M 148738, I/A 33 (3.01.13).

09 de Marzo de 2012
Ceses/Dimisiones. Secretario: AGIO SERVICIOS CENTRALIZADOS SA. Cons.Del.Sol: AGIO SERVICIOS CENTRALIZADOS SA.Con.Delegado: THEBOOM CREYF MARIANNE GABRIELLE. Representan: CAMPS GUERRERO JOSE MARIA. Nombramientos.Representan: THEBOOM CREYF MARIANNE GABRIELLE. Con.Delegado: THEBOOM CREYF MARIANNE GABRIELLE.SecreNoConsj: HERRERO TEJEDOR ALGAR CARLOS. Reelecciones. Consejero: CREYF HERMAN HARRY PETER;AGIOSERVICIOS CENTRALIZADOS SA;THEBOOM CREYF MARIANNE GABRIELLE. Presidente: THEBOOM CREYF MARIANNEGABRIELLE. Datos registrales. T 15214 , F 95, S 8, H M 148738, I/A 31 (28.02.12).

Revocaciones. Apo.Manc.: BERROCAL VELASCO ARACELI;CORTINA DE LA HERRAN JULIAN EDUARDO;LASAGA GILADOLORES ANGELES;GUTIERREZ GARCIA CRISTINA. Nombramientos. Apoderado: BERROCAL VELASCO ARACELI;CORTINADE LA HERRAN JULIAN EDUARDO;CAMPS GUERRERO JOSE MARIA;GUTIERREZ GARCIA CRISTINA;RODRIGUEZ SANCHEZANGEL LUIS;BELIEN NADINE LODEWIJK MARTHA;DAVID MARTIN SANCHEZ. Datos registrales. T 15214 , F 97, S 8, H M148738, I/A 32 (28.02.12).

24 de Febrero de 2011
Reelecciones. Auditor: ADHOC AUDITORES SL. Datos registrales. T 15214 , F 95, S 8, H M 148738, I/A 30 (14.02.11).

17 de Noviembre de 2009
Cambio de domicilio social. GTA DE QUEVEDO 9 - 3º (MADRID). Datos registrales. T 15214 , F 95, S 8, H M 148738, I/A 29 (3.11.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información